CRONKINSON DEVELOPMENTS LIMITED

CRONKINSON DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCRONKINSON DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03300328
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CRONKINSON DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CRONKINSON DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    WESTBURY
    2nd Floor 145-157 St John Street
    EC1V 4PY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CRONKINSON DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BODYDOWN LIMITED09 gen 199709 gen 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di CRONKINSON DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CRONKINSON DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 gen 2016

    Stato del capitale al 18 gen 2016

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 gen 2015

    Stato del capitale al 22 gen 2015

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 feb 2014

    Stato del capitale al 11 feb 2014

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 set 2011 al 31 dic 2010

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2010 al 30 set 2010

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Kenneth Finken il 05 gen 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 1 Hillingdon Road Uxbridge Middlesex UB10 0AA* in data 19 nov 2009

    1 pagineAD01

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di CRONKINSON DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FINCKEN, Kenneth John
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    6-8
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    6-8
    Middlesex
    United Kingdom
    BritishDirector137669180002
    BESSER, Andrew Brian
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    Segretario
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    British51126420001
    CONROY, Peter David
    Clareswood House
    93 Silverdale Avenue
    KT12 1EJ Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    Clareswood House
    93 Silverdale Avenue
    KT12 1EJ Walton On Thames
    Surrey
    BritishChartered Accountant35089490002
    HUGHES, Maureen Patricia
    Mulberry Cottage Irene Road
    BR6 0HA Orpington
    Kent
    Segretario
    Mulberry Cottage Irene Road
    BR6 0HA Orpington
    Kent
    British3069310002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    FINCKEN, Paul Edward
    Elm Lodge
    Chinnor Road
    OX49 5SH Aston Rowant
    Amministratore
    Elm Lodge
    Chinnor Road
    OX49 5SH Aston Rowant
    United KingdomBritishDirector109887450001
    SOLOMONS, Nicola Jane
    20d Randolph Crescent
    W9 1DR London
    Amministratore
    20d Randolph Crescent
    W9 1DR London
    United KingdomBritishSolicitor5585590001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    NANTWICH DEVELOPMENTS LIMITED
    28 Savile Row
    W1S 2EU London
    Amministratore
    28 Savile Row
    W1S 2EU London
    51470400003

    CRONKINSON DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 13 dic 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    55 audlem rd,nantwich cheshire; t/no ch 110074 with all fixed buildings and other structures; the goodwill of business or undertaking; all fixed plant machinery and other items affixed thereto; all rental sums and benefit of all rights and remedies; all insurance proceeds under any insurance policy. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 01 dic 1997
    Consegnato il 13 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Woodview and greenfield house farm audlem road nantwich; t/no ch 407954. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 dic 1997
    Consegnato il 13 dic 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at stapeley farm,audlem rd,nantwich CW5 7DT; t/no CH349788. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 01 dic 1997
    Consegnato il 13 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge by the company and nantwich developments limited and north west estates (nantwich) limited as mortgagor by the company as trustee for mortgagor and by north west estates PLC as principal debtor
    Creato il 01 set 1997
    Consegnato il 11 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from north west estates PLC as principal debtor to the chargee and on any account whatsoever; provided that the total sum recoverable under the charge shall be limited to the sum of £200,000
    Brevi particolari
    Land and buildings at stapeley farm, audlem road, nantwich cheshire t/no: CH349788.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 feb 1997
    Consegnato il 07 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and other sums due in relation to the indebtedness this deed or any guarantee or security
    Brevi particolari
    The company charges its undertaking and all its property and other assets of whatsoever nature both present and future including its uncalled capital for the time being (the "charged property") with full title guarantee and security hereby created shall rank by way of: a fixed charge on f/h land and buildings at stapeley farm audlem road nantwich t/n-CH349788 and all buildings fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery from time to time on any such f/h l/h and other immovable property; a fixed charge by way of legal mortgage on the plant and machinery chattels vehicles computures and/or other equipment; a fixed charge by way of assignment on all its goodwill and by way of fixed charge its uncalled capital; a fixed charge by way of legal assignment on the book debts and all other monetary debts and claims.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Baltic Property Finance PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0