DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED
Panoramica
Nome della società | DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03300794 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 40a Station Road RM14 2TR Upminster Essex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
FUTURE MORTGAGES LIMITED | 01 nov 2004 | 01 nov 2004 |
FUTURE MORTGAGES 1 LTD | 02 ott 1998 | 02 ott 1998 |
FUTURE MORTGAGE 1 LIMITED | 28 gen 1997 | 28 gen 1997 |
DECORNICE LIMITED | 10 gen 1997 | 10 gen 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms. Helena Paivi Whitaker il 17 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX England a 40a Station Road Upminster Essex RM14 2TR in data 25 apr 2023 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Daniel Marc Richard Jaffe come amministratore in data 01 feb 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2021 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2020 al 30 giu 2021 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Intertrust Corporate Services Limited il 16 mar 2020 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 35 Great St. Helen's London EC3A 6AP a 1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX in data 14 apr 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Paivi Helena Whitaker il 07 nov 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Helena Paivi Whitaker il 11 set 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Daniel Marc Richard Jaffe come amministratore in data 20 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Claudia Ann Wallace come amministratore in data 20 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 15 pagine | AAMD | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERTRUST CORPORATE SERVICES LIMITED | Segretario | Bartholomew Lane EC2N 2AX London 1 England |
| 70578490003 | ||||||||||
WHITAKER, Paivi Helena | Amministratore | Station Road RM14 2TR Upminster 40a Essex | United Kingdom | Finnish | Director | 305048350001 | ||||||||
BELL, Stuart William | Segretario | 65 Deanfield Road RG9 1UU Henley On Thames Oxfordshire | British | Company Secretary | 56340160001 | |||||||||
CUMMING, Simon James | Segretario | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 | British | 108590800001 | ||||||||||
EDWARDS, Christine Ann | Segretario | Cornerstone Church Town Court, Backwell BS48 3JF Bristol | British | Accountant | 78476890001 | |||||||||
GAULTER, Andrew Martin | Segretario | Willows End 39 Linden Grove KT12 1EY Walton On Thames Surrey | British | Solicitor | 3751650002 | |||||||||
KEAST, Timothy John | Segretario | Manor Farm House Spring Lane East Dundry BS41 8NT Bristol | British | Director | 66564900001 | |||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
ABBOTT, Mark Darryll | Amministratore | 24 Beech Drive N2 9NY London | British | Investment Banker | 47493340002 | |||||||||
BERRY, Robert William | Amministratore | Great St Helens EC3A 6AP London 35 United Kingdom | England | British | Director | 64303740002 | ||||||||
COBB, James Robert | Amministratore | 12 The Deerings AL5 2PE Harpenden Hertfordshire | England | British | Uk Consumer Cfo | 122932220001 | ||||||||
CULHANE, Michael Charles | Amministratore | 139 Oakwood Court W14 8JS London | Great Britain | British | Investment Banker | 141310100001 | ||||||||
DUFFELL, Alan Michael | Amministratore | Canada Square Canary Wharf E14 5LB London Citigroup Centre England | England | British | Director | 160552200002 | ||||||||
FARACE, Andrea | Amministratore | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 | United Kingdom | Italian | Investment Banker | 130545760003 | ||||||||
HALL, Michael John | Amministratore | The Copse Moore End Freith RG9 6PS Henley On Thames Oxfordshire | British | Director | 251390001 | |||||||||
HARRINGTON, Kurt Ross | Amministratore | 14300 Brickhowe Court 20874 Darnestown Maryland Usa | American | Treasurer | 53161750001 | |||||||||
JAFFE, Daniel Marc Richard | Amministratore | Bartholomew Lane EC2N 2AX London 1 England | England | British | Director | 248923570001 | ||||||||
KEAST, Timothy John | Amministratore | Manor Farm House Spring Lane East Dundry BS41 8NT Bristol | United Kingdom | British | Director | 66564900001 | ||||||||
KERR, Ian David | Amministratore | 2/5 Drumsheugh Gardens EH3 7QT Edinburgh | British | Country Business Manager | 117069040001 | |||||||||
KORNREICH, Joel | Amministratore | Canada Square Canary Wharf E14 5LB London Citigroup Centre England | Spain | Belgian | Coo Western Europe Consumer Banking | 157016790001 | ||||||||
LYALL, Nicholas Mark Edward | Amministratore | 45 Nannyhagen Thornwood 10594 United States | British | Deputy Chief Financial Officer | 112857970001 | |||||||||
MALONE, Daniel Martin | Amministratore | Solas House 2 Dark Lane RG10 8JU Wargrave Berkshire | England | Irish | Director | 111339860001 | ||||||||
MER, Nandan | Amministratore | 4 Maida Vale W2 1TF London | Indian | Country Business Manager Gcg | 113002690001 | |||||||||
MILNE, Duncan Andrew | Amministratore | Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf E14 5LB London | England | British | Solicitor | 159439200001 | ||||||||
MISTRY, Jiten Vasantkumar | Amministratore | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 | England | British | Analyst | 200594180001 | ||||||||
PIJILS, Henricus Lambertus | Amministratore | Frensham Road Lower Bourne GU10 3PZ Farnham Cricketview House Surrey | British | Banker | 134478840001 | |||||||||
PIJLS, Henricus Lambertus | Amministratore | Frensham Road GU10 3PZ Farnham Cricketview House Surrey | England | Dutch | Banker | 130074340001 | ||||||||
PIJLS, Henricus Lambertus | Amministratore | Frensham Road Lower Bourne GU10 3PZ Farnham Cricketview House Surrey | England | Dutch | Banker | 130074340001 | ||||||||
RYAN, Gerard Jude | Amministratore | Cove Cottage 11 Ashley Drive KT12 1JL Walton On Thames Surrey | Irish | Cfo Emea Consumer | 121738300001 | |||||||||
SABEL, Michael | Amministratore | 3333 N.St. Nw 5 20007 Washington D.C. U.S.A. | U.S.A. | Investment Banker | 51338240001 | |||||||||
SARUP, Sarvesh | Amministratore | 14 Abbey Lodge Park Road NW8 7RJ London | Indian | Banker | 113161820001 | |||||||||
SHAKESPEARE, Susan Gail | Amministratore | Chartwell House Hancocks Mount SL5 9PQ Ascot Berkshire | England | British | Chief Financial Officer | 63291370003 | ||||||||
SHERMAN, Arthur Haag | Amministratore | 2419 Avalon Place 77019 Houston Texas 77019 Usa | American | Executive Vice President Redst | 67181490001 | |||||||||
SINGH, Surinder Pal | Amministratore | Flat 5 Princes Gate Court Exhibition Road SW7 2QJ London | United States Citizen | Managing Director | 111894440002 | |||||||||
STYLES, Desmond Guy | Amministratore | 2 Park Road Sale M33 6WX Manchester | British | Director | 48371120002 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
20 mag 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Amendment and restatement agreement relating to a debenture dated 6TH march 1997 | Creato il 01 giu 2000 Consegnato il 17 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The secured obligations at the times and in the manner provided in the debenture,the facility agreement and other such documents as may constitute or evidence any secured obligations and any other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All right title and interest in the occupiers consents,the guarantee,buildings policies,lsi policy and transaction documents by way of floating charge all undertaking property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 06 mar 1997 Consegnato il 19 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari With full title guarantee each of the english mortgages and all rights title and benefits in the english loans all rights title and interest in the occupiers consents,the life charges and guarantees,the lsi policy and all bonuses all right title and interest in the fml agreement the hml agreement and the ffc guarantee the us pledge and the subordinated loan agreement by way of floating chargethe whole of the undertaking all property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
DUKINFIELD MORTGAGES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0