B&C (REALISATIONS) LIMITED
Panoramica
Nome della società | B&C (REALISATIONS) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03302426 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di B&C (REALISATIONS) LIMITED?
- altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
- rilegatura e servizi correlati (18140) / Industrie manifatturiere
Dove si trova B&C (REALISATIONS) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Chaucer Business Park Launton Road OX26 4QZ Bicester Oxfordshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di B&C (REALISATIONS) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BENHAM & COMPANY LIMITED | 08 apr 1997 | 08 apr 1997 |
MUTANDERIS (267) LIMITED | 14 gen 1997 | 14 gen 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di B&C (REALISATIONS) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mag 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per B&C (REALISATIONS) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Ian Edwards come amministratore in data 28 nov 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed benham & company LIMITED\certificate issued on 29/11/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di David Alan Holland come amministratore in data 28 nov 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Alan Holland come segretario in data 28 nov 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 mag 2010 | 4 pagine | AAMD | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2009 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mag 2008 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mag 2007 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mag 2006 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b |
Chi sono gli amministratori di B&C (REALISATIONS) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARDS, Michael Ian | Amministratore | Chaucer Business Park Launton Road OX26 4QZ Bicester Oxfordshire | England | British | None | 151050100001 | ||||
CROSSLEY, Peter Graham | Segretario | 62 Church Hill IG10 1LB Loughton Essex | British | Director | 51437100001 | |||||
HILLMAN, David | Segretario | St. Margarets Station Road, Thorrington CO7 8JA Colchester Essex | British | Director | 56527380002 | |||||
HILLMAN, David | Segretario | St. Margarets Station Road, Thorrington CO7 8JA Colchester Essex | British | Director | 56527380002 | |||||
HOLLAND, David Alan | Segretario | The Chestnuts Long Green, Wortham IP22 1RD Diss Norfolk | British | Chairman | 97792830001 | |||||
NEWLAND, Nicholas John | Segretario | Manor Farm OX29 7NT Curbridge Oxfordshire | British | Company Director | 31070880001 | |||||
NEWLAND, Nicholas John | Segretario | Manor Farm OX29 7NT Curbridge Oxfordshire | British | Company Director | 31070880001 | |||||
BART MANAGEMENT LIMITED | Segretario nominato | C/O Laytons Carmelite 5th Floor 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0LS London | 900005790001 | |||||||
COOLING, John Alfred | Amministratore | 14 Bisham Gardens Highgate N6 6DD London | England | British | Company Director | 224465730001 | ||||
CROSSLEY, Peter Graham | Amministratore | 62 Church Hill IG10 1LB Loughton Essex | England | British | Director | 51437100001 | ||||
ENGLAND, Ronald William | Amministratore | Regency Court 147 Alan Road IP3 8DP Ipswich Suffolk | British | Company Director | 76922580004 | |||||
HILLMAN, David | Amministratore | St. Margarets Station Road, Thorrington CO7 8JA Colchester Essex | England | British | Director | 56527380002 | ||||
HILLMAN, David | Amministratore | St. Margarets Station Road, Thorrington CO7 8JA Colchester Essex | England | British | Director | 56527380002 | ||||
HOLLAND, David Alan | Amministratore | The Chestnuts Long Green, Wortham IP22 1RD Diss Norfolk | England | British | Chairman | 97792830001 | ||||
NEWLAND, Nicholas John | Amministratore | Manor Farm OX29 7NT Curbridge Oxfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 31070880001 | ||||
SIMONS, Peter Andrew Stephen | Amministratore | Swallows 1a High Street Earls Colne CO6 2PA Colchester Essex | British | Director | 113829420001 | |||||
WARDHAUGH, Martin | Amministratore | 3 Collingwood Fields East Bergholt CO7 6QN Colchester Essex | British | Director | 34988850001 | |||||
BART SECRETARIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | C/O Laytons Carmelite 5th Floor 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0LS London | 900005780001 |
B&C (REALISATIONS) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Chattels mortgage | Creato il 05 ott 2001 Consegnato il 05 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 2 x muller martini cb-16 book stackers, 2 x ROTR4 strapping machines, 8 x technology integrators slc-1000 signature log clamps, 1 x crane gantry system. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 04 lug 1997 Consegnato il 18 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 apr 1997 Consegnato il 16 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly known as mutanderis (267) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Property k/a land and buildings on the east side of severalls lane colchester essex t/n EX464765. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0