ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED

ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03303086
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    • fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (25110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Dalton Airfield
    Industrial Estate Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ATLAS WARD STRUCTURES LIMITED14 feb 199714 feb 1997
    KINGSPAN STRUCTURES LIMITED10 gen 199710 gen 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2015

    Stato del capitale al 07 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan David Dunsmore il 30 mag 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di James Richard Gordon Martindale come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nigel Pickard come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 gen 2014

    Stato del capitale al 10 gen 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Emerson come amministratore

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Peter Barnes il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Nigel Pickard il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    Nomina di Darrell Ward come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Alan David Dunsmore come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Davison come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Peter Davison come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WARD, Darrell
    Industrial Estate Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Industrial Estate Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield
    North Yorkshire
    United Kingdom
    162903900001
    BARNES, Simon Peter
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector73812400001
    DUNSMORE, Alan David
    Industrial Estate Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Industrial Estate Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector157389760001
    MARTINDALE, James Richard Gordon
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector110076240001
    ALLY, Bibi Rahima
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    Segretario
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    British38963210007
    DAVISON, Peter Jeffrey
    Sheraton Park
    Blackwell
    DL3 8QY Darlington
    County Durham
    Segretario
    Sheraton Park
    Blackwell
    DL3 8QY Darlington
    County Durham
    British17502280003
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Segretario
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrishDirector145024250001
    REYNOLDS, Pamela
    The Mount
    Quarry Hill
    HX6 3BQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Segretario
    The Mount
    Quarry Hill
    HX6 3BQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    BritishAccountant91736390004
    SYLVESTER, Graham
    Woodcote,
    Coulton, Hovingham
    YO62 4NE York
    North Yorkshire
    Segretario
    Woodcote,
    Coulton, Hovingham
    YO62 4NE York
    North Yorkshire
    British66711190001
    WYATT, Ian Edward Andrew
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    BritishFinance Director9514330002
    WYATT, Ian Edward Andrew
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    BritishFinance Director9514330002
    ANDERSON, Kenneth
    The Cottage
    12 Hay Lane
    YO13 0SP Scalby
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Cottage
    12 Hay Lane
    YO13 0SP Scalby
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director151458410001
    COLLETT, Brian
    10 Norwich Street
    EC4A 1BD London
    Amministratore
    10 Norwich Street
    EC4A 1BD London
    BritishCompany Director32267100001
    CRIMMINS, Mark
    11 Lightfoots Close
    YO12 5NR Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    11 Lightfoots Close
    YO12 5NR Scarborough
    North Yorkshire
    IrishCompany Director51812810001
    DAVISON, Peter Jeffrey
    Sheraton Park
    Blackwell
    DL3 8QY Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Sheraton Park
    Blackwell
    DL3 8QY Darlington
    County Durham
    EnglandBritishDirector17502280003
    EMERSON, Peter Arthur
    Linden House
    Southwell Road Kirklington
    NG22 8NF Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Linden House
    Southwell Road Kirklington
    NG22 8NF Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector14955940002
    GOLDBERG, Thomas Guy
    Catlaine Manor North Cattleholmes
    Wansford
    YO25 8NW Driffield
    Amministratore
    Catlaine Manor North Cattleholmes
    Wansford
    YO25 8NW Driffield
    United KingdomBritishDirector73445850001
    HAMILTON, Thomas Robertson
    Broadacres 13 Earswick Chase
    Old Earswick
    YO32 9FZ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Broadacres 13 Earswick Chase
    Old Earswick
    YO32 9FZ York
    North Yorkshire
    BritishDirector80213780003
    LEVINE, Peter Michael
    Alpenstrasse 15.
    Postfach 4853, C/O Refidar Moore
    Stephens
    Zug Ch6304
    Switzerland
    Amministratore
    Alpenstrasse 15.
    Postfach 4853, C/O Refidar Moore
    Stephens
    Zug Ch6304
    Switzerland
    BritishDirector110141340002
    MCCARTHY, Eoin
    Cabra
    Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    Amministratore
    Cabra
    Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    IrishDirector21221020001
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Amministratore
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrelandIrishDirector145024250001
    MURTAGH, Brendan
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    Amministratore
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    IrishDirector30924190002
    MURTAGH, Eugene
    Lios Na Carraige
    IRISH Kingscourt
    Cavan
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    Lios Na Carraige
    IRISH Kingscourt
    Cavan
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishDirector16536550001
    PICKARD, Nigel
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector78976080001
    RHEINHARDT, Rolf
    Nibelungenring 23
    Stutensee
    FOREIGN 76297 Germany
    Amministratore
    Nibelungenring 23
    Stutensee
    FOREIGN 76297 Germany
    GermanGeneral Manager53912100001
    SEVERS, John Leslie
    Holme House Farm
    Raisbeck
    CA10 3SG Penrith
    Cumbria
    Amministratore
    Holme House Farm
    Raisbeck
    CA10 3SG Penrith
    Cumbria
    EnglandBritishDirector5333970003
    WYATT, Ian Edward Andrew
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director9514330002

    ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 15 mag 1997
    Consegnato il 28 mag 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a land and buildings at sherburn malton north yorkshire fixed charge all buildings and other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property, assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies, fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 15 mag 1997
    Consegnato il 28 mag 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 lug 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 15 mag 1997
    Consegnato il 17 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any person who is designated a lender under the loan agreement dated 15TH may 1997 pursuant to a deed of guarantee and indemnity dated 15TH may 1997
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Plcacting for Itself and as Security Trustee on Behalf of the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 17 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 lug 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 mag 1997
    Consegnato il 17 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any person who is designated a lender under a loan agreement dated 15TH may 1997 pursuant to a deed of guarantee and indemnity dated 15TH may 1997
    Brevi particolari
    L/H property k/a land and buildings at sherburn malton north yorkshire with all buildings and fixtures fixed plant and machinery and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • 3I Plcacting for Itself and as Security Trustee on Behalf of the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 17 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0