ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED
Panoramica
Nome della società | ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03303086 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
- fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (25110) / Industrie manifatturiere
Dove si trova ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Dalton Airfield Industrial Estate Dalton YO7 3JN Thirsk North Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ATLAS WARD STRUCTURES LIMITED | 14 feb 1997 | 14 feb 1997 |
KINGSPAN STRUCTURES LIMITED | 10 gen 1997 | 10 gen 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan David Dunsmore il 30 mag 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di James Richard Gordon Martindale come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel Pickard come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Emerson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2012 al 31 mar 2013 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Simon Peter Barnes il 01 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Nigel Pickard il 01 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Darrell Ward come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Alan David Dunsmore come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Davison come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Davison come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARD, Darrell | Segretario | Industrial Estate Dalton YO7 3JN Thirsk Dalton Airfield North Yorkshire United Kingdom | 162903900001 | |||||||
BARNES, Simon Peter | Amministratore | Dalton YO7 3JN Thirsk Dalton Airfield Industrial Estate North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 73812400001 | ||||
DUNSMORE, Alan David | Amministratore | Industrial Estate Dalton YO7 3JN Thirsk Dalton Airfield North Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 157389760001 | ||||
MARTINDALE, James Richard Gordon | Amministratore | Dalton YO7 3JN Thirsk Dalton Airfield Industrial Estate North Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 110076240001 | ||||
ALLY, Bibi Rahima | Segretario | Norwich Street EC4A 1BD London 10 | British | 38963210007 | ||||||
DAVISON, Peter Jeffrey | Segretario | Sheraton Park Blackwell DL3 8QY Darlington County Durham | British | 17502280003 | ||||||
MULVIHILL, Dermot | Segretario | Cloverhill Balrath Road Kells Meath Ireland | Irish | Director | 145024250001 | |||||
REYNOLDS, Pamela | Segretario | The Mount Quarry Hill HX6 3BQ Sowerby Bridge West Yorkshire | British | Accountant | 91736390004 | |||||
SYLVESTER, Graham | Segretario | Woodcote, Coulton, Hovingham YO62 4NE York North Yorkshire | British | 66711190001 | ||||||
WYATT, Ian Edward Andrew | Segretario | 30 Deepdale Avenue YO11 2UF Scarborough North Yorkshire | British | Finance Director | 9514330002 | |||||
WYATT, Ian Edward Andrew | Segretario | 30 Deepdale Avenue YO11 2UF Scarborough North Yorkshire | British | Finance Director | 9514330002 | |||||
ANDERSON, Kenneth | Amministratore | The Cottage 12 Hay Lane YO13 0SP Scalby North Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 151458410001 | ||||
COLLETT, Brian | Amministratore | 10 Norwich Street EC4A 1BD London | British | Company Director | 32267100001 | |||||
CRIMMINS, Mark | Amministratore | 11 Lightfoots Close YO12 5NR Scarborough North Yorkshire | Irish | Company Director | 51812810001 | |||||
DAVISON, Peter Jeffrey | Amministratore | Sheraton Park Blackwell DL3 8QY Darlington County Durham | England | British | Director | 17502280003 | ||||
EMERSON, Peter Arthur | Amministratore | Linden House Southwell Road Kirklington NG22 8NF Newark Nottinghamshire | England | British | Director | 14955940002 | ||||
GOLDBERG, Thomas Guy | Amministratore | Catlaine Manor North Cattleholmes Wansford YO25 8NW Driffield | United Kingdom | British | Director | 73445850001 | ||||
HAMILTON, Thomas Robertson | Amministratore | Broadacres 13 Earswick Chase Old Earswick YO32 9FZ York North Yorkshire | British | Director | 80213780003 | |||||
LEVINE, Peter Michael | Amministratore | Alpenstrasse 15. Postfach 4853, C/O Refidar Moore Stephens Zug Ch6304 Switzerland | British | Director | 110141340002 | |||||
MCCARTHY, Eoin | Amministratore | Cabra Kingscourt Co.Cavan Ireland | Irish | Director | 21221020001 | |||||
MULVIHILL, Dermot | Amministratore | Cloverhill Balrath Road Kells Meath Ireland | Ireland | Irish | Director | 145024250001 | ||||
MURTAGH, Brendan | Amministratore | Dunheeda IRISH Kingscourt Co.Cavan Ireland | Irish | Director | 30924190002 | |||||
MURTAGH, Eugene | Amministratore | Lios Na Carraige IRISH Kingscourt Cavan Republic Of Ireland | Ireland | Irish | Director | 16536550001 | ||||
PICKARD, Nigel | Amministratore | Dalton YO7 3JN Thirsk Dalton Airfield Industrial Estate North Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 78976080001 | ||||
RHEINHARDT, Rolf | Amministratore | Nibelungenring 23 Stutensee FOREIGN 76297 Germany | German | General Manager | 53912100001 | |||||
SEVERS, John Leslie | Amministratore | Holme House Farm Raisbeck CA10 3SG Penrith Cumbria | England | British | Director | 5333970003 | ||||
WYATT, Ian Edward Andrew | Amministratore | 30 Deepdale Avenue YO11 2UF Scarborough North Yorkshire | England | British | Finance Director | 9514330002 |
ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 15 mag 1997 Consegnato il 28 mag 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The l/h property k/a land and buildings at sherburn malton north yorkshire fixed charge all buildings and other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property, assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies, fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 mag 1997 Consegnato il 28 mag 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 mag 1997 Consegnato il 17 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and any person who is designated a lender under the loan agreement dated 15TH may 1997 pursuant to a deed of guarantee and indemnity dated 15TH may 1997 | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 15 mag 1997 Consegnato il 17 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and any person who is designated a lender under a loan agreement dated 15TH may 1997 pursuant to a deed of guarantee and indemnity dated 15TH may 1997 | |
Brevi particolari L/H property k/a land and buildings at sherburn malton north yorkshire with all buildings and fixtures fixed plant and machinery and the proceeds of sale thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0