X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED

X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàX L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03303903
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del segretario cambiati per Gillian Elizabeth James il 31 mar 2011

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Robert Charles Gale il 31 mar 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 gen 2012

    Stato del capitale al 26 gen 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Joanne Christine Tillbrook come amministratore in data 16 set 2011

    3 pagineAP01
    Note
    DataNota
    27 gen 2012Clarification The document is a duplicate of AP01 registered on 02/11/2011

    Cessazione della carica di Joanne Christine Tillbrook come amministratore in data 16 set 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Joanne Christine Tillbrook come amministratore in data 16 set 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Mario Mackenzie come amministratore in data 20 feb 2002

    1 pagineTM01

    Nomina di Joanne Christine Tillbrook come amministratore in data 16 set 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Mario Mackenzie come amministratore in data 16 set 2011

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 160 Great Portland Street London W1W 5QA in data 31 mar 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    legacy

    25 pagineMG01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Virgin Media Secretaries Limited come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagineMG04

    Cessazione della carica di Virgin Media Directors Limited come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Segretario
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    151391230001
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Segretario
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Segretario
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Segretario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    PHILLIPS, Derek Norman
    10 Lawrence Crescent
    Richmond
    DL10 5QE Darlington
    North Yorkshire
    Segretario
    10 Lawrence Crescent
    Richmond
    DL10 5QE Darlington
    North Yorkshire
    British51107720001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Segretario
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    CAMPBELL, Edward Heron
    Dromonby View Dromonby House
    Busby Lane
    TS9 7AP Kirkby
    Cleveland
    Amministratore
    Dromonby View Dromonby House
    Busby Lane
    TS9 7AP Kirkby
    Cleveland
    Canadian50976920003
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Amministratore
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Amministratore
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Amministratore
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    KNAPP, James Barclay
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Amministratore
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Us Citizen79688880001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Amministratore
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Amministratore
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MCKELLAR, Ronald Alexander
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    British7345780001
    PHILLIPS, Derek Norman
    10 Lawrence Crescent
    Richmond
    DL10 5QE Darlington
    North Yorkshire
    Amministratore
    10 Lawrence Crescent
    Richmond
    DL10 5QE Darlington
    North Yorkshire
    United KingdomBritish51107720001
    RICHTER, Bret
    245 East 63rd Street
    Apartment 20h
    10021 New York
    New York
    United States
    Amministratore
    245 East 63rd Street
    Apartment 20h
    10021 New York
    New York
    United States
    American86830760001
    ROBERTS, Gareth Nigel Christopher
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    Amministratore
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    British145824690001
    ROSS, Stuart
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Amministratore
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    EnglandBritish20168110001
    SCHUBERT, Scott Elliott
    9 William Street House
    William Street
    SW1X 9HH London
    Amministratore
    9 William Street House
    William Street
    SW1X 9HH London
    American89618040001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    WOOD, Leigh
    The Priory 10 Hambledon Park
    Hambledon
    GU8 4ER Godalming
    Surrey
    Amministratore
    The Priory 10 Hambledon Park
    Hambledon
    GU8 4ER Godalming
    Surrey
    American53880530001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 29 giu 2010
    Consegnato il 08 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 08 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Confirmation deed
    Creato il 15 apr 2010
    Consegnato il 29 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 29 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite debenture
    Creato il 19 gen 2010
    Consegnato il 22 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite debenture
    Creato il 19 gen 2010
    Consegnato il 22 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Creato il 16 giu 2006
    Consegnato il 29 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 29 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 10 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 24 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 giu 2004
    Consegnato il 30 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston
    Transazioni
    • 30 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0