PCV HP NOMINEE LIMITED

PCV HP NOMINEE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPCV HP NOMINEE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03309232
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PCV HP NOMINEE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FREEHOLD PORTFOLIOS HP NOMINEE LIMITED23 gen 199723 gen 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 set 2018

    6 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 set 2017

    6 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 set 2016

    4 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:court order - removal/ replacement of liquidator
    30 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 set 2015

    4 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a 15 Canada Square London E14 5GL in data 17 ott 2015

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ a 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB in data 16 ott 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 set 2014

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 08 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2014

    Stato del capitale al 08 gen 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 17 set 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 17 set 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Segretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Australian57113450003
    GROSE, David Leonard
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House
    Amministratore
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House
    United KingdomBritish120479020002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish6815470021
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    Amministratore
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritish155262770001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    LINEOBTAIN LIMITED
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    Segretario
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    87536870003
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritish100504300001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Amministratore
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    EVANS, Alasdair David
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    Amministratore
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    United KingdomBritish130019430001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    British33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    British93017010002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Amministratore
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Amministratore
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Amministratore
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritish4779170003
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    PCV HP NOMINEE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 15 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All shares held by the company and/or any nominee on it's behalf and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branch,(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 15 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 lug 2001
    Consegnato il 02 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Brevi particolari
    All that f/h land k/a 35 broad street and 29-31 queen victoria street,reading title absolute under t/n BK115467. For further details of all property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, as Agent and Trustee Tothe Finance Parties (The Agent)
    Transazioni
    • 02 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 18TH february 2000 and
    Creato il 09 feb 2000
    Consegnato il 29 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as freehold portfolios hp nominee limited) and/or any other obligor to each senior finance party under each senior finance document or each mezzanine finance party under each mezzanine finance document
    Brevi particolari
    All and whole those shop premises with ancillary office accommodation on the basement, ground and first floors in the burgh of falkirk and county of stirling now k/a numbers 118 to 120 high street falkirk t/no STG10222. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank as Agent and Trusteefor Itself and the Other Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between the company (formerly known as freehold portfolios hp nominee limited) each chargor and the security trustee
    Creato il 09 feb 2000
    Consegnato il 21 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whather actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to a). Each senior finance party under each senior finance document; or b). Each mezzanine finance party under each mezzanine finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985.
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutchen Bank, London Branch(As Agent and Trustee for the Senior Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties)
    Transazioni
    • 21 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rents
    Creato il 09 feb 2000
    Consegnato il 19 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to each senior finance party under each senior finance document or each mazzanine finance party under each mezzanine finance document (all defined therein)
    Brevi particolari
    Right, title and interest in and to the rental income in respect of the subjects (as defined).
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank, London Branch, Asagent and Trustee for Itself and the Other Finance Parties ("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 19 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security dated 05 july 1999 which was registered in scotland on 12 july 1999
    Creato il 12 lug 1999
    Consegnato il 28 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or each other borrower to the agent as lender, agent one of the arrangers and original counterparty and its successors and assignees whomsoever and to each other finance party under or pursuant to a credit agreement dated 05 july 1999
    Brevi particolari
    Property k/a numbers one hundred and eighteen to one hundred and twenty high street falkirk t/n stg 10222.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and the Other Financeparties
    Transazioni
    • 28 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rents
    Creato il 07 lug 1999
    Consegnato il 15 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The companys right, title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement).
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transazioni
    • 15 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 lug 1999
    Consegnato il 20 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies whatsoever due or to become due from each borrower (as defined) and fp financial to each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft,London Branch,as Agent and Trustee for Thefinance Parties
    Transazioni
    • 20 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rents
    Creato il 14 gen 1999
    Consegnato il 26 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and the other finance parties (as defined in the credit agreement dated 21ST october 1998) under or pursuant to the credit agreement and any finance document referred to as such in the credit agreement
    Brevi particolari
    The company's right title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement) payable in respect of the leases of the subjects.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Ag
    Transazioni
    • 26 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 gen 1999
    Consegnato il 19 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined)under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    16 toll gavel beverley 33 parliament street york f/h property k/a 35 broad street and 29-31 queen victoria street reading t/nos: HS200862 NYK127042 BK115467 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transazioni
    • 19 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 25 january 1999 and
    Creato il 05 gen 1999
    Consegnato il 30 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or each other borrower (as defined) under or pursuant to a credit agreement dated 21 october 1998
    Brevi particolari
    The property known as 118 to 120 high street falkirk title number STG10222.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Theother Finance Parties ("Agent")
    Transazioni
    • 30 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 04 feb 1997
    Consegnato il 20 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The properties being 189 high street, southend on sea-EX166546 and the other properties described on the schedule attached to the form M395 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon, rights, licences, leases and a floating charge over the property, assets, rights and revenues including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 20 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of charge
    Creato il 04 feb 1997
    Consegnato il 20 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By clause 2 of the assignment all the right, titles, benefits and interests to all monies owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of 189 high street, southend on sea-EX166546 and all the other properties described in the schedule attached to the form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 20 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PCV HP NOMINEE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 feb 2019Data di scioglimento
    23 set 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0