LDC (CULVER) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LDC (CULVER) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03310934 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LDC (CULVER) LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova LDC (CULVER) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Core 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LDC (CULVER) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RIDGEMADE LIMITED | 31 gen 1997 | 31 gen 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LDC (CULVER) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LDC (CULVER) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per LDC (CULVER) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Christopher Allan come amministratore in data 20 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come amministratore in data 30 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 04 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 09 set 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Reid come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LDC (CULVER) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Segretario | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | British | 175753180001 | ||||||
| SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Amministratore | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | United Kingdom | British | 175753180001 | |||||
| RANSOME, David Peter | Segretario | Silver Birches Stinchcombe Hill GL11 6AQ Dursley Gloucestershire | British | 67258390002 | ||||||
| REID, Andrew Donald | Segretario | 15 Cranbrook Road Redland BS6 7BJ Bristol | British | 67884910002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALLAN, Mark Christopher | Amministratore | 40 St. Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | United Kingdom | British | 74371010003 | |||||
| GRIFFIN, Peter Andrew Travers | Amministratore | Charnwood House Croft Lane SN6 6DP Latton Wiltshire | British | 72762880001 | ||||||
| KURASH, Perry Ian | Amministratore | 16 Heath Road Clapham SW8 3BU London | British | 50553980001 | ||||||
| PORTER, Nicholas Anthony | Amministratore | Ridge House Horse Race Lane Failand BS8 3TX Bristol | British | 45837900004 | ||||||
| RANSOME, David Peter | Amministratore | Silver Birches Stinchcombe Hill GL11 6AQ Dursley Gloucestershire | England | British | 67258390002 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
LDC (CULVER) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 20 mar 1997 Consegnato il 21 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 26 park street and culver house culver street bristol t/n BL29824 and BL29825 including all fixtures fittings fixed plant and machinery thereon (other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 mar 1997 Consegnato il 21 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari First floating charge all the undertaking and assets present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 26 feb 1997 Consegnato il 07 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of a loan agreement dated 26TH february 1997, the legal charge, the documents (as defined in the loan agreement), any other transaction between the company and the chargee and any other monies due | |
Brevi particolari F/H property k/a culver house and 26 park street bristol t/nos.BL29825 and BL29824 including all buildings fixtures fixed plant and machinery, benefit of all contracts deeds undertakings agreements rights warranties securities licences patents copyrights design rights and other rights insurance policies and contracts of insurance. By way of floating charge all the undertaking and all other property assets and rights including goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0