STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED

STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTILES HAROLD WILLIAMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03311644
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    • Attività di agenzie immobiliari (68310) / Attività immobiliari

    Dove si trova STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CANNONGUARD LIMITED03 feb 199703 feb 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    16 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 mar 2017

    15 pagine4.68

    Memorandum e Statuto

    26 pagineMA

    Indirizzo della sede legale modificato da Venture House 27/29 Glasshouse Street London W1B 5DF a 2-3 Pavilion Buildings Brighton East Sussex BN1 1EE in data 19 apr 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 mar 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di Mr Peter John Sharpe Turner come amministratore in data 04 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sarah Jean Webb come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Carol Gillian Williams come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Garnett Wade come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard James Turner come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter John Sharpe Turner come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Kevin Spruce come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Stephen Skelton come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Clive Richardson come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Norton Ray come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard William Antranik Pyne come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Neale Todd Plant come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Niral Harshadbhai Patel come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Fredric Victor Perry come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Niall Mcguinness come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Haydon Lee Murton come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Scanlan Mcfadden come amministratore in data 04 mar 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCHOLEFIELD, Andrew
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    Segretario
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    182004020001
    CLARK, Martin Robert
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    Amministratore
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    EnglandBritish60233030002
    GODFREY, Adam Barnaby
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    Amministratore
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    United KingdomBritish52957710002
    STAPLETON, Richard Harvey
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    Amministratore
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    United KingdomBritish52691090001
    TURNER, Peter John Sharpe
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    Amministratore
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    EnglandBritish59460040001
    DAGWELL, Robert Shawn
    61 Copse Avenue
    Layhams Road
    BR4 9HN West Wickham
    Kent
    Segretario
    61 Copse Avenue
    Layhams Road
    BR4 9HN West Wickham
    Kent
    British148874200001
    POLLARD, Remi Constant Chenery
    6 Babmaes Street
    London
    SW1Y 6HD
    Segretario
    6 Babmaes Street
    London
    SW1Y 6HD
    British52691060001
    M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    Segretario nominato
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    900007890001
    ALLEN-SHALLESS, Trudi Jane
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    EnglandBritish21506920002
    ASBURY, Ian
    North Bank House
    Cross Hill Road
    OX17 3EQ West Adderbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    North Bank House
    Cross Hill Road
    OX17 3EQ West Adderbury
    Oxfordshire
    British93810120001
    BARKER, Neil Stewart
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish127956210002
    BRADBEER, Nicholas Charles
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish71855470002
    BRADLEY SMITH, Robert Charles
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish82523240002
    CANNING, Spencer George Stratford De Redcliffe, Hon
    1 Church Street
    Little Bedwyn
    SN8 3JQ Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    1 Church Street
    Little Bedwyn
    SN8 3JQ Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritish37931560001
    CANTWELL, Philip Joseph
    8 Oak Ridge
    West End
    GU24 9PJ Woking
    Surrey
    Amministratore
    8 Oak Ridge
    West End
    GU24 9PJ Woking
    Surrey
    British66803840001
    CLARK, Vanessa Elizabeth
    11 Annandale Road
    Chiswick
    W4 2HE London
    Amministratore
    11 Annandale Road
    Chiswick
    W4 2HE London
    EnglandBritish56357200002
    CLEVERTON, John Neil
    Maycroft Muddles Green
    BN21 4UP Chiddingly
    East Sussex
    Amministratore
    Maycroft Muddles Green
    BN21 4UP Chiddingly
    East Sussex
    United KingdomBritish8500140003
    COLDBREATH, Peter Stuart
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish86987380002
    COOMBER, Ian Frederick
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    EnglandBritish150632140001
    COTTELL, Peter Michael
    6 Troymede
    RH17 6LU Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    6 Troymede
    RH17 6LU Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish115306040001
    COX, Howard Ashley
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish123098020001
    DAGWELL, Robert Shawn
    61 Copse Avenue
    Layhams Road
    BR4 9HN West Wickham
    Kent
    Amministratore
    61 Copse Avenue
    Layhams Road
    BR4 9HN West Wickham
    Kent
    British148874200001
    DAVIES, John Simon
    9 Hyde Park Crescent
    W2 2PY London
    Amministratore
    9 Hyde Park Crescent
    W2 2PY London
    EnglandBritish10482150004
    DICKMAN, Jonathan Saul
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish110260430001
    ENGLISH, Greville John Reginald
    Glebe Cottage
    31 Lower Street
    RH20 2BH Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Glebe Cottage
    31 Lower Street
    RH20 2BH Pulborough
    West Sussex
    British59459880004
    EVANS, Nigel John Wilson
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    EnglandBritish59459500001
    FLETCHER, Trevor Peter
    37 Newbolt Avenue
    SM3 8ED Cheam
    Surrey
    Amministratore
    37 Newbolt Avenue
    SM3 8ED Cheam
    Surrey
    British95383350001
    FORD, Nigel Kevin
    67 Stamford Green Road
    KT18 7SR Epsom
    Surrey
    Amministratore
    67 Stamford Green Road
    KT18 7SR Epsom
    Surrey
    British59460170002
    GREENWOOD, Timothy Ian
    46 Bonehurst Road
    RH6 8QG Horley
    Surrey
    Amministratore
    46 Bonehurst Road
    RH6 8QG Horley
    Surrey
    United KingdomBritish74487050002
    HADDEN, David George
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    EnglandBritish62211360001
    HAMMOND, John Philip Arthur
    The Bothy Tandridge Court
    Tandridge Lane
    RH8 9NJ Oxted
    Amministratore
    The Bothy Tandridge Court
    Tandridge Lane
    RH8 9NJ Oxted
    EnglandBritish52957650002
    HARDWICKE, Timothy Robert
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish98537020002
    HEARD, Robert William
    Brook Cottage
    Wilton
    SN8 3SS Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Brook Cottage
    Wilton
    SN8 3SS Marlborough
    Wiltshire
    British72313470001
    HITCH, Nicholas Charles
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    UkBritish60750750002
    HUNT, Simon Russell
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Amministratore
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    UkBritish110260330001

    STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 gen 2012
    Consegnato il 12 gen 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 29 giu 1999
    Consegnato il 03 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £44,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The rent deposit and the deposit balance with full guarantee as security for the performance of the obligations of the tenant under the lease.
    Persone aventi diritto
    • Hambleden Group Limited
    Transazioni
    • 03 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 feb 1999
    Consegnato il 04 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 apr 1997
    Consegnato il 30 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an assets purchase agreement dated 28TH april 1997
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stiles Harold Williams Limited
    Transazioni
    • 30 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 mar 2016Inizio della liquidazione
    10 ago 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Walters
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Praticante
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Jonathan James Beard
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Praticante
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0