STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03311644 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
- Attività di agenzie immobiliari (68310) / Attività immobiliari
Dove si trova STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 2-3 Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton East Sussex |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CANNONGUARD LIMITED | 03 feb 1997 | 03 feb 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 16 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 mar 2017 | 15 pagine | 4.68 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 26 pagine | MA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Venture House 27/29 Glasshouse Street London W1B 5DF a 2-3 Pavilion Buildings Brighton East Sussex BN1 1EE in data 19 apr 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di Mr Peter John Sharpe Turner come amministratore in data 04 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Jean Webb come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Carol Gillian Williams come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Garnett Wade come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard James Turner come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter John Sharpe Turner come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Kevin Spruce come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Stephen Skelton come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Clive Richardson come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Norton Ray come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard William Antranik Pyne come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Neale Todd Plant come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Niral Harshadbhai Patel come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Fredric Victor Perry come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Niall Mcguinness come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Haydon Lee Murton come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Scanlan Mcfadden come amministratore in data 04 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOLEFIELD, Andrew | Segretario | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | 182004020001 | |||||||
| CLARK, Martin Robert | Amministratore | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | England | British | 60233030002 | |||||
| GODFREY, Adam Barnaby | Amministratore | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | United Kingdom | British | 52957710002 | |||||
| STAPLETON, Richard Harvey | Amministratore | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | United Kingdom | British | 52691090001 | |||||
| TURNER, Peter John Sharpe | Amministratore | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | England | British | 59460040001 | |||||
| DAGWELL, Robert Shawn | Segretario | 61 Copse Avenue Layhams Road BR4 9HN West Wickham Kent | British | 148874200001 | ||||||
| POLLARD, Remi Constant Chenery | Segretario | 6 Babmaes Street London SW1Y 6HD | British | 52691060001 | ||||||
| M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED | Segretario nominato | Regent House 316 Beulah Hill SE19 3HP London | 900007890001 | |||||||
| ALLEN-SHALLESS, Trudi Jane | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 21506920002 | |||||
| ASBURY, Ian | Amministratore | North Bank House Cross Hill Road OX17 3EQ West Adderbury Oxfordshire | British | 93810120001 | ||||||
| BARKER, Neil Stewart | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 127956210002 | |||||
| BRADBEER, Nicholas Charles | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 71855470002 | |||||
| BRADLEY SMITH, Robert Charles | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 82523240002 | |||||
| CANNING, Spencer George Stratford De Redcliffe, Hon | Amministratore | 1 Church Street Little Bedwyn SN8 3JQ Marlborough Wiltshire | United Kingdom | British | 37931560001 | |||||
| CANTWELL, Philip Joseph | Amministratore | 8 Oak Ridge West End GU24 9PJ Woking Surrey | British | 66803840001 | ||||||
| CLARK, Vanessa Elizabeth | Amministratore | 11 Annandale Road Chiswick W4 2HE London | England | British | 56357200002 | |||||
| CLEVERTON, John Neil | Amministratore | Maycroft Muddles Green BN21 4UP Chiddingly East Sussex | United Kingdom | British | 8500140003 | |||||
| COLDBREATH, Peter Stuart | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 86987380002 | |||||
| COOMBER, Ian Frederick | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 150632140001 | |||||
| COTTELL, Peter Michael | Amministratore | 6 Troymede RH17 6LU Haywards Heath West Sussex | England | British | 115306040001 | |||||
| COX, Howard Ashley | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 123098020001 | |||||
| DAGWELL, Robert Shawn | Amministratore | 61 Copse Avenue Layhams Road BR4 9HN West Wickham Kent | British | 148874200001 | ||||||
| DAVIES, John Simon | Amministratore | 9 Hyde Park Crescent W2 2PY London | England | British | 10482150004 | |||||
| DICKMAN, Jonathan Saul | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 110260430001 | |||||
| ENGLISH, Greville John Reginald | Amministratore | Glebe Cottage 31 Lower Street RH20 2BH Pulborough West Sussex | British | 59459880004 | ||||||
| EVANS, Nigel John Wilson | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 59459500001 | |||||
| FLETCHER, Trevor Peter | Amministratore | 37 Newbolt Avenue SM3 8ED Cheam Surrey | British | 95383350001 | ||||||
| FORD, Nigel Kevin | Amministratore | 67 Stamford Green Road KT18 7SR Epsom Surrey | British | 59460170002 | ||||||
| GREENWOOD, Timothy Ian | Amministratore | 46 Bonehurst Road RH6 8QG Horley Surrey | United Kingdom | British | 74487050002 | |||||
| HADDEN, David George | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 62211360001 | |||||
| HAMMOND, John Philip Arthur | Amministratore | The Bothy Tandridge Court Tandridge Lane RH8 9NJ Oxted | England | British | 52957650002 | |||||
| HARDWICKE, Timothy Robert | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 98537020002 | |||||
| HEARD, Robert William | Amministratore | Brook Cottage Wilton SN8 3SS Marlborough Wiltshire | British | 72313470001 | ||||||
| HITCH, Nicholas Charles | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | Uk | British | 60750750002 | |||||
| HUNT, Simon Russell | Amministratore | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | Uk | British | 110260330001 |
STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 06 gen 2012 Consegnato il 12 gen 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 29 giu 1999 Consegnato il 03 lug 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £44,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The rent deposit and the deposit balance with full guarantee as security for the performance of the obligations of the tenant under the lease. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 02 feb 1999 Consegnato il 04 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 apr 1997 Consegnato il 30 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an assets purchase agreement dated 28TH april 1997 | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0