ATEGO SYSTEMS LIMITED

ATEGO SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàATEGO SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03313467
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ATEGO SYSTEMS LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ATEGO SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ATEGO SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARTISAN SOFTWARE TOOLS LIMITED22 lug 199722 lug 1997
    XENA REAL TIME LIMITED07 mar 199707 mar 1997
    OVAL (1168) LIMITED05 feb 199705 feb 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di ATEGO SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per ATEGO SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Abbey House 282 Farnborough Road Farnborough Hampshire GU14 7NA England a 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS in data 20 ott 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 set 2017

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 22 set 2017

    • Capitale: GBP 0.01
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 18/09/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    15 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Chester House Farnborough Aerospace Centre Farnborough GU14 6TQ a Abbey House 282 Farnborough Road Farnborough Hampshire GU14 7NA in data 19 giu 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 apr 2016

    Stato del capitale al 05 apr 2016

    • Capitale: GBP 2,600,148.16
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Charles Christopher William Dunn il 09 nov 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Charles Dunn il 09 nov 2015

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    21 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di ATEGO SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUNN, Charles
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Segretario
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    British189732650001
    DUNN, Charles Christopher William
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    United KingdomBritishDirector58831370005
    KIBBLE, Peter
    Suite 701 Eagle Tower
    Montpellier Drive
    GL50 1TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Suite 701 Eagle Tower
    Montpellier Drive
    GL50 1TA Cheltenham
    Gloucestershire
    160494210001
    KIERNAN, David Thomas
    3 Powick Mills
    Old Road
    WR2 4BU Worcester
    Segretario
    3 Powick Mills
    Old Road
    WR2 4BU Worcester
    BritishFinancial Controller74782080002
    LAWRENCE, Kevin
    Suite 701 Eagle Tower
    Montpellier Drive
    GL50 1TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Suite 701 Eagle Tower
    Montpellier Drive
    GL50 1TA Cheltenham
    Gloucestershire
    168064170001
    MCWILLIAM, Katherine
    Suite 701 Eagle Tower
    Montpellier Drive
    GL50 1TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Suite 701 Eagle Tower
    Montpellier Drive
    GL50 1TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British155681850001
    MOORHEAD, Paul Raymond
    Cherry Tree Cottage 10 Cuttle Lane
    Biddestone
    SN14 7DA Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    Cherry Tree Cottage 10 Cuttle Lane
    Biddestone
    SN14 7DA Chippenham
    Wiltshire
    BritishSoftware52646780001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Segretario nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    ACLAND, Simon Hugh Verdon
    Charlwood Lodge
    42 Charlwood Road Putney
    SW15 1PW London
    Amministratore
    Charlwood Lodge
    42 Charlwood Road Putney
    SW15 1PW London
    United KingdomBritishVenture Capitalist15257290003
    ALEXANDER, David Turnbull
    36 Tournay Road
    SW6 7UF London
    Amministratore
    36 Tournay Road
    SW6 7UF London
    BritishInvestment Manager94005750001
    CATANIA, Michael Angelo
    Bryn Onnen
    Llandegla Road, Llanarmon-Yn-Ial
    CH7 4QX Mold
    Denbighshire
    Amministratore
    Bryn Onnen
    Llandegla Road, Llanarmon-Yn-Ial
    CH7 4QX Mold
    Denbighshire
    United KingdomMalteseTechnical Director Software En102833680001
    CESARINI, Pierre
    Tenterden Street
    W1S 1TA London
    1
    Amministratore
    Tenterden Street
    W1S 1TA London
    1
    FranceFrenchDirector150397220001
    GAMBRELL, James Bruton
    Apartment 1301 Point West
    116 Cromwell Road
    SW7 4XN London
    Amministratore
    Apartment 1301 Point West
    116 Cromwell Road
    SW7 4XN London
    United KingdomAmericanCompany Director121842770001
    GERA, Michael
    Flat 3, 227 Sussex Gardens
    W2 2RL London
    Amministratore
    Flat 3, 227 Sussex Gardens
    W2 2RL London
    United KingdomBritishVenture Capitalist81211900001
    GOULDING, Jeremy William
    9 Grosvenor Villas
    BA1 6QL Bath
    Avon
    Amministratore
    9 Grosvenor Villas
    BA1 6QL Bath
    Avon
    United KingdomBritishDir Of Ww Sales66917230003
    HORSMAN, Richard John
    Suite 701 Eagle Tower
    Montpellier Drive
    GL50 1TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Suite 701 Eagle Tower
    Montpellier Drive
    GL50 1TA Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector186375150001
    IRVING, Richard Henry
    15615 Oakridge Court
    Morgan Hill
    Ca 95037
    United States
    Amministratore
    15615 Oakridge Court
    Morgan Hill
    Ca 95037
    United States
    United StatesAmericanVenture Capitalist58247620001
    KIERNAN, David Thomas
    Tenterden Street
    W1S 1TA London
    1
    Amministratore
    Tenterden Street
    W1S 1TA London
    1
    United KingdomBritishFinancial Director74782080002
    LAWRENCE, Kevin Brian
    Suite 701 Eagle Tower
    Montpellier Drive
    GL50 1TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Suite 701 Eagle Tower
    Montpellier Drive
    GL50 1TA Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChief Financial Officer169886380001
    MILNE, Jeremy Bruce
    Pollards Hill Farm
    Worthing Road Southwater
    RH13 9DN Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Pollards Hill Farm
    Worthing Road Southwater
    RH13 9DN Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishVenture Capitalist104349940001
    MOORHEAD, Paul Raymond
    Cherry Tree Cottage 10 Cuttle Lane
    Biddestone
    SN14 7DA Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Cherry Tree Cottage 10 Cuttle Lane
    Biddestone
    SN14 7DA Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director52646780001
    OBRIEN, Stephen Caine
    15790 Sw Bobwhite Circle
    Beaverton
    Or 97007
    Usa
    Amministratore
    15790 Sw Bobwhite Circle
    Beaverton
    Or 97007
    Usa
    AmericanCeo68247250002
    PASSMORE, Walter William
    Gardenside
    Higher Metcombe
    EX11 1SR Ottery St Mary
    Devon
    Amministratore
    Gardenside
    Higher Metcombe
    EX11 1SR Ottery St Mary
    Devon
    BritishCompany Director53532920001
    PHILLIPS, Michael
    11 The Withers
    Bishops Cleeve
    GL52 4WE Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    11 The Withers
    Bishops Cleeve
    GL52 4WE Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAnalyst58390680001
    STEVENS, Alan Charles
    Lorne House Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lorne House Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishManagement Consultant32033570002
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Amministratore delegato nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Amministratore delegato nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    SPARK DIRECTORS LIMITED
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    Amministratore
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    131352460001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ATEGO SYSTEMS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Atego Group Ltd
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6TQ Farnborough
    Chester House
    Hants
    England
    01 feb 2017
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6TQ Farnborough
    Chester House
    Hants
    England
    No
    Forma giuridicaLtd
    Autorità legaleLimited Company
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    ATEGO SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Contract over the pledge of company shares
    Creato il 04 ott 2012
    Consegnato il 19 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The pledged shares, all acquisition rights, all monetary claims and rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eso Investco I S.A.R.L., Kings Arms Yard Vct PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second lender supplemental debenture
    Creato il 09 ago 2012
    Consegnato il 10 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the second lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the benefit of all material contracts; and all rights and interest under or in respect of any other agreement see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kings Arms Yard Vct PLC
    Transazioni
    • 10 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A first lender supplemental debenture
    Creato il 09 ago 2012
    Consegnato il 10 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the first lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the benefit of all material contracts; and all rights and interest under or in respect of any other agreement see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eso Investco I S.A.R.L
    Transazioni
    • 10 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second lender guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2012
    Consegnato il 07 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kings Arms Yard Vct PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    First lender guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2012
    Consegnato il 07 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eso Investco I S.A.R.L.
    Transazioni
    • 07 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage over securities
    Creato il 06 lug 2012
    Consegnato il 12 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the second lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the shares and the dividends see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kings Arms Yard Vct PLC
    Transazioni
    • 12 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage over securities
    Creato il 06 lug 2012
    Consegnato il 12 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the first lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the shares and the dividends see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eso Investco I S.A.R.L
    Transazioni
    • 12 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 mag 2002
    Consegnato il 31 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the investors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC (Or Such Other Persons as May from Time to Time Be the Security Trustee for Thepurposes of the Said Charge) for Itself and as Trustee for the Investors
    Transazioni
    • 31 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 ago 2001
    Consegnato il 13 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the company's obligations and liabilities to the chargee contained in the investment agreement of even date and this deed from time to time
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC as Security Trustee for Itself and the Other Investors (Asdefined Therein)
    Transazioni
    • 13 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 feb 2000
    Consegnato il 11 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Quester Vct PLC
    • Quester Vct 2 PLC
    Transazioni
    • 11 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 feb 2000
    Consegnato il 17 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to pond ventures I L.P., an english limited partnership acting by its manager, pond venture partners limited and defta-pond co-investment, L.P., a delaware limited partnership acting by its manager, pond venture partners limited (other than dividend on any shares)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Defta-Pond Co-Investment,L.P.
    • Pond Ventures I L.P.
    Transazioni
    • 17 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of intellectual property rights
    Creato il 04 feb 2000
    Consegnato il 15 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charges on such part of the materials (as defined) now in existence and owned by the company; and such part of the materials not yet in existence but created or acquired by the company after the date of the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 15 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 feb 2000
    Consegnato il 15 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 15 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 25 mar 1999
    Consegnato il 10 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 mar 1999
    Consegnato il 10 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quester Vct PLC and Quester Vct 2 PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of intellectual property rights
    Creato il 25 mar 1999
    Consegnato il 10 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on such part of materials now in existence (as defined) and all sketches drawings/property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ATEGO SYSTEMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 set 2017Inizio della liquidazione
    12 gen 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0