ALARIC SYSTEMS LIMITED

ALARIC SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALARIC SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03314005
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALARIC SYSTEMS LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ALARIC SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    9th Floor 5 Merchant Square
    W2 1BQ London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALARIC SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AST SYSTEMS LIMITED06 feb 199706 feb 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALARIC SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ALARIC SYSTEMS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ALARIC SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 dic 2015

    • Capitale: GBP 0.01
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancelling the share premium account. 15/12/2015
    RES13

    Indirizzo della sede legale modificato da 206-216 Marylebone Road London NW1 6LY a 9th Floor 5 Merchant Square London W2 1BQ in data 08 mag 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2015

    Stato del capitale al 08 apr 2015

    • Capitale: GBP 161,855.99
    SH01

    Cessazione della carica di Marcus Jai Wright come amministratore in data 01 dic 2014

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Helen Louise Wilde come amministratore in data 27 ott 2014

    4 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter David Parke come amministratore in data 31 lug 2014

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael John Alford come amministratore in data 31 lug 2014

    2 pagineTM01

    Nomina di Caroline Amanda Kee come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Miss Caroline Amanda Kee come amministratore in data 02 dic 2013

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    23 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    13 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 mar 2014

    Stato del capitale al 06 mar 2014

    • Capitale: GBP 161,855.99
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    31 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Increae nom cap 05/11/2013
    RES13
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Nomina di Helen Louise Wilde come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Spencer Clarke come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Rachel Victoria Nash come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Marcus Jai Wright come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel Potts come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Timothy Levett come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ALARIC SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARKE, Spencer
    Pencisely Avenue
    Canton
    CF5 1DZ Cardiff
    12
    South Glamorgan
    Amministratore
    Pencisely Avenue
    Canton
    CF5 1DZ Cardiff
    12
    South Glamorgan
    United KingdomBritish180202620001
    KEE, Caroline Amanda
    Deacon Road
    NW2 5NP London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Deacon Road
    NW2 5NP London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomIrish151461990001
    NASH, Rachel Victoria
    Tewit Well Avenue
    HG2 8AP Harrogate
    12
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tewit Well Avenue
    HG2 8AP Harrogate
    12
    North Yorkshire
    United KingdomBritish128364390001
    GIBBONS, David John
    26 Eastwick Drive
    KT23 3PR Great Bookham
    Surrey
    Segretario
    26 Eastwick Drive
    KT23 3PR Great Bookham
    Surrey
    British142535280001
    LAZARUS, Heather Ann
    3 Wimmerfield Crescent
    Killay
    SA2 7BU Swansea
    West Glamorgan
    Wales
    Segretario nominato
    3 Wimmerfield Crescent
    Killay
    SA2 7BU Swansea
    West Glamorgan
    Wales
    British900001810001
    MITCHELL, Andrew Robert
    13 Verran Road
    GU15 2ND Camberley
    Surrey
    Segretario
    13 Verran Road
    GU15 2ND Camberley
    Surrey
    British4666500001
    MITCHELL, Andrew Robert
    13 Verran Road
    GU15 2ND Camberley
    Surrey
    Segretario
    13 Verran Road
    GU15 2ND Camberley
    Surrey
    British4666500001
    POTTS, Daniel James
    Marylebone Road
    NW1 6LY London
    206-216
    Segretario
    Marylebone Road
    NW1 6LY London
    206-216
    169718390001
    SWALE, Margaret Elizabeth
    2 Brookside Fold
    Oxenhope
    BD22 9HQ Keighley
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Brookside Fold
    Oxenhope
    BD22 9HQ Keighley
    West Yorkshire
    British58716180002
    ALFORD, Michael John, Dr
    13 Speed House
    Barbican
    EC2Y 8AT London
    Amministratore
    13 Speed House
    Barbican
    EC2Y 8AT London
    EnglandBritish67065020002
    AMOS, Mervin
    30 Ewelme Road
    Forest Hill
    SE23 3BH London
    Amministratore
    30 Ewelme Road
    Forest Hill
    SE23 3BH London
    EnglandBritish119748850001
    AMOS, Mervin
    30a Ewelme Road
    Forest Hill
    SE23 3BH London
    Amministratore
    30a Ewelme Road
    Forest Hill
    SE23 3BH London
    British54720670001
    BARTON, Howard
    15 King Street
    Drighlington
    BD11 1EJ Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 King Street
    Drighlington
    BD11 1EJ Bradford
    West Yorkshire
    British59814910002
    BOVE, Peter John
    5 Woodhill House
    Kentish Lane
    AL9 6JY Essendon
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Woodhill House
    Kentish Lane
    AL9 6JY Essendon
    Hertfordshire
    British84313120001
    GIBBONS, David John
    26 Eastwick Drive
    KT23 3PR Great Bookham
    Surrey
    Amministratore
    26 Eastwick Drive
    KT23 3PR Great Bookham
    Surrey
    EnglandBritish142535280001
    GRIFFIN, Paul Joseph
    20 Trees
    Jalan 203d
    Kuala Lumpur
    9-3-2
    Taman Melawati 53100
    Malaysia
    Amministratore
    20 Trees
    Jalan 203d
    Kuala Lumpur
    9-3-2
    Taman Melawati 53100
    Malaysia
    MalaysiaBritish149364980002
    HUGHES, David Michael
    6 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    6 Merrydown Way
    BR7 5RS Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritish15718340001
    KOVACHEVICH, Zlatan
    30 Blenheim Gardens
    KT2 7BW Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    30 Blenheim Gardens
    KT2 7BW Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish119748800001
    LAZARUS, Harry Pierre
    3 Wimmerfield Crescent
    Killay
    SA2 7BU Swansea
    West Glamorgan
    Wales
    Amministratore delegato nominato
    3 Wimmerfield Crescent
    Killay
    SA2 7BU Swansea
    West Glamorgan
    Wales
    British900001820001
    LEVETT, Timothy Roland
    8 Tankerville Terrace
    Jesmond
    NE2 3AH Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    8 Tankerville Terrace
    Jesmond
    NE2 3AH Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish2586350004
    LOMAX, Stephen John David, Mr.
    15 Cambridge Square
    RH1 6TG Redhill
    Surrey
    Amministratore
    15 Cambridge Square
    RH1 6TG Redhill
    Surrey
    EnglandBritish117650690001
    MACLENNAN, Donald Alexander
    20 Sherenden Park
    Golden Green
    TN11 0LQ Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    20 Sherenden Park
    Golden Green
    TN11 0LQ Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish31750180001
    PARKE, Peter David
    The Bungalow
    Priors Hatch Lane Hurtmore
    GU7 2RJ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    The Bungalow
    Priors Hatch Lane Hurtmore
    GU7 2RJ Godalming
    Surrey
    EnglandBritish8469340001
    ROBINSON, Peter John
    6 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Potters Bar
    Hertfordshire
    British75921750001
    SHONE, Michael Leslie
    Delamead
    Onslow Road Sunningdale
    SL5 0HW Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Delamead
    Onslow Road Sunningdale
    SL5 0HW Ascot
    Berkshire
    British63582950005
    SPENCER, Anthony
    12 St Pauls Road East
    RH4 2HR Dorking
    Surrey
    Amministratore
    12 St Pauls Road East
    RH4 2HR Dorking
    Surrey
    British15665650001
    SWALE, Carl
    Buttergate Sykes Barn Sykes Lane
    Leeming Oxenhope
    BD22 9SH Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Buttergate Sykes Barn Sykes Lane
    Leeming Oxenhope
    BD22 9SH Keighley
    West Yorkshire
    British51403590001
    SWALE, Margaret Elizabeth
    2 Brookside Fold
    Oxenhope
    BD22 9HQ Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Brookside Fold
    Oxenhope
    BD22 9HQ Keighley
    West Yorkshire
    British58716180002
    TAIT, Michael John
    Brookbank
    HP10 0QB Wooburn Green
    Turpins
    Bucks
    Amministratore
    Brookbank
    HP10 0QB Wooburn Green
    Turpins
    Bucks
    United KingdomBritish129158460001
    WILDE, Helen Louise
    Slayley View Road
    Barlborough
    S43 4WU Chesterfield
    64
    Derbyshire
    Amministratore
    Slayley View Road
    Barlborough
    S43 4WU Chesterfield
    64
    Derbyshire
    United KingdomBritish153939250001
    WRIGHT, Marcus Jai
    Ryhall Road
    PE9 1UL Stamford
    129
    Lincolnshire
    Amministratore
    Ryhall Road
    PE9 1UL Stamford
    129
    Lincolnshire
    EnglandBritish180202950001

    ALARIC SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 09 giu 2011
    Consegnato il 17 giu 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £40,620,.60 plus all sums in the account standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Breast Cancer Care and Overcourt Limited
    Transazioni
    • 17 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 27 mag 2008
    Consegnato il 04 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nvm Private Equity Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 ago 2007
    Consegnato il 13 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nvm Private Equity Limited (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 13 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 giu 2004
    Consegnato il 03 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The amount of the £435,000.00 variable rate secured a loan stock 2009 and all other sums due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Northern Venture Managers Limited (As Security Trustee for the Holders of the Loan Stock Fromtime to Time the Stockholder)
    Transazioni
    • 03 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 giu 2004
    Consegnato il 03 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The amount of the £65,000.00 variable rate secured b loan stock 2009 and all other sums due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Michael John Alford (As Security Trustee for the Holders of the Loan Stock from Time to Timethe Stockholder)
    Transazioni
    • 03 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 giu 1998
    Consegnato il 29 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0