ALARIC SYSTEMS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ALARIC SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03314005 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ALARIC SYSTEMS LIMITED?
- Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
Dove si trova ALARIC SYSTEMS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 9th Floor 5 Merchant Square W2 1BQ London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ALARIC SYSTEMS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| AST SYSTEMS LIMITED | 06 feb 1997 | 06 feb 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ALARIC SYSTEMS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ALARIC SYSTEMS LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per ALARIC SYSTEMS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||||||||||
Stato del capitale al 17 dic 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 206-216 Marylebone Road London NW1 6LY a 9th Floor 5 Merchant Square London W2 1BQ in data 08 mag 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Marcus Jai Wright come amministratore in data 01 dic 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Helen Louise Wilde come amministratore in data 27 ott 2014 | 4 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter David Parke come amministratore in data 31 lug 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael John Alford come amministratore in data 31 lug 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Nomina di Caroline Amanda Kee come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Nomina di Miss Caroline Amanda Kee come amministratore in data 02 dic 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 23 pagine | AA | ||||||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 13 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 31 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Nomina di Helen Louise Wilde come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Nomina di Spencer Clarke come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Nomina di Rachel Victoria Nash come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Nomina di Marcus Jai Wright come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Daniel Potts come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Levett come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ALARIC SYSTEMS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Spencer | Amministratore | Pencisely Avenue Canton CF5 1DZ Cardiff 12 South Glamorgan | United Kingdom | British | 180202620001 | |||||
| KEE, Caroline Amanda | Amministratore | Deacon Road NW2 5NP London 7a United Kingdom | United Kingdom | Irish | 151461990001 | |||||
| NASH, Rachel Victoria | Amministratore | Tewit Well Avenue HG2 8AP Harrogate 12 North Yorkshire | United Kingdom | British | 128364390001 | |||||
| GIBBONS, David John | Segretario | 26 Eastwick Drive KT23 3PR Great Bookham Surrey | British | 142535280001 | ||||||
| LAZARUS, Heather Ann | Segretario nominato | 3 Wimmerfield Crescent Killay SA2 7BU Swansea West Glamorgan Wales | British | 900001810001 | ||||||
| MITCHELL, Andrew Robert | Segretario | 13 Verran Road GU15 2ND Camberley Surrey | British | 4666500001 | ||||||
| MITCHELL, Andrew Robert | Segretario | 13 Verran Road GU15 2ND Camberley Surrey | British | 4666500001 | ||||||
| POTTS, Daniel James | Segretario | Marylebone Road NW1 6LY London 206-216 | 169718390001 | |||||||
| SWALE, Margaret Elizabeth | Segretario | 2 Brookside Fold Oxenhope BD22 9HQ Keighley West Yorkshire | British | 58716180002 | ||||||
| ALFORD, Michael John, Dr | Amministratore | 13 Speed House Barbican EC2Y 8AT London | England | British | 67065020002 | |||||
| AMOS, Mervin | Amministratore | 30 Ewelme Road Forest Hill SE23 3BH London | England | British | 119748850001 | |||||
| AMOS, Mervin | Amministratore | 30a Ewelme Road Forest Hill SE23 3BH London | British | 54720670001 | ||||||
| BARTON, Howard | Amministratore | 15 King Street Drighlington BD11 1EJ Bradford West Yorkshire | British | 59814910002 | ||||||
| BOVE, Peter John | Amministratore | 5 Woodhill House Kentish Lane AL9 6JY Essendon Hertfordshire | British | 84313120001 | ||||||
| GIBBONS, David John | Amministratore | 26 Eastwick Drive KT23 3PR Great Bookham Surrey | England | British | 142535280001 | |||||
| GRIFFIN, Paul Joseph | Amministratore | 20 Trees Jalan 203d Kuala Lumpur 9-3-2 Taman Melawati 53100 Malaysia | Malaysia | British | 149364980002 | |||||
| HUGHES, David Michael | Amministratore | 6 Merrydown Way BR7 5RS Chislehurst Kent | United Kingdom | British | 15718340001 | |||||
| KOVACHEVICH, Zlatan | Amministratore | 30 Blenheim Gardens KT2 7BW Kingston Upon Thames Surrey | England | British | 119748800001 | |||||
| LAZARUS, Harry Pierre | Amministratore delegato nominato | 3 Wimmerfield Crescent Killay SA2 7BU Swansea West Glamorgan Wales | British | 900001820001 | ||||||
| LEVETT, Timothy Roland | Amministratore | 8 Tankerville Terrace Jesmond NE2 3AH Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 2586350004 | |||||
| LOMAX, Stephen John David, Mr. | Amministratore | 15 Cambridge Square RH1 6TG Redhill Surrey | England | British | 117650690001 | |||||
| MACLENNAN, Donald Alexander | Amministratore | 20 Sherenden Park Golden Green TN11 0LQ Tonbridge Kent | England | British | 31750180001 | |||||
| PARKE, Peter David | Amministratore | The Bungalow Priors Hatch Lane Hurtmore GU7 2RJ Godalming Surrey | England | British | 8469340001 | |||||
| ROBINSON, Peter John | Amministratore | 6 Northaw Place Coopers Lane EN6 4NQ Potters Bar Hertfordshire | British | 75921750001 | ||||||
| SHONE, Michael Leslie | Amministratore | Delamead Onslow Road Sunningdale SL5 0HW Ascot Berkshire | British | 63582950005 | ||||||
| SPENCER, Anthony | Amministratore | 12 St Pauls Road East RH4 2HR Dorking Surrey | British | 15665650001 | ||||||
| SWALE, Carl | Amministratore | Buttergate Sykes Barn Sykes Lane Leeming Oxenhope BD22 9SH Keighley West Yorkshire | British | 51403590001 | ||||||
| SWALE, Margaret Elizabeth | Amministratore | 2 Brookside Fold Oxenhope BD22 9HQ Keighley West Yorkshire | British | 58716180002 | ||||||
| TAIT, Michael John | Amministratore | Brookbank HP10 0QB Wooburn Green Turpins Bucks | United Kingdom | British | 129158460001 | |||||
| WILDE, Helen Louise | Amministratore | Slayley View Road Barlborough S43 4WU Chesterfield 64 Derbyshire | United Kingdom | British | 153939250001 | |||||
| WRIGHT, Marcus Jai | Amministratore | Ryhall Road PE9 1UL Stamford 129 Lincolnshire | England | British | 180202950001 |
ALARIC SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 09 giu 2011 Consegnato il 17 giu 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £40,620,.60 plus all sums in the account standing to the credit of the account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 27 mag 2008 Consegnato il 04 giu 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 ago 2007 Consegnato il 13 set 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 giu 2004 Consegnato il 03 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The amount of the £435,000.00 variable rate secured a loan stock 2009 and all other sums due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 giu 2004 Consegnato il 03 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The amount of the £65,000.00 variable rate secured b loan stock 2009 and all other sums due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 giu 1998 Consegnato il 29 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0