VANTAGE DISTRIBUTION LTD

VANTAGE DISTRIBUTION LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVANTAGE DISTRIBUTION LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03314092
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VANTAGE DISTRIBUTION LTD?

    • Commercio all'ingrosso di apparecchi radiofonici, televisivi ed elettrodomestici (esclusi nastri magnetici, dischi, CD e videocassette e le apparecchiature per la loro riproduzione) (46439) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova VANTAGE DISTRIBUTION LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VANTAGE DISTRIBUTION LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    REGENERSIS DISTRIBUTION LTD06 giu 200806 giu 2008
    INTEC DISTRIBUTION LIMITED10 ago 199810 ago 1998
    BETA BUSINESS LIMITED06 feb 199706 feb 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di VANTAGE DISTRIBUTION LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per VANTAGE DISTRIBUTION LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2017

    13 pagineLIQ03

    Dettagli del segretario cambiati per Lorraine Young Company Secretaries Limited il 22 dic 2016

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR United Kingdom a Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD in data 26 ott 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 set 2016

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da 190 High Street Tonbridge Kent TN9 1BE a 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR in data 02 set 2016

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    15 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed regenersis distribution LTD\certificate issued on 24/03/16
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name24 mar 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 23 mar 2016

    RES15

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mar 2016

    Stato del capitale al 02 mar 2016

    • Capitale: GBP 50,000
    • Capitale: USD 500
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jog Dhody il 17 nov 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jog Dhody il 23 giu 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mar 2015

    Stato del capitale al 05 mar 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    • Capitale: USD 500
    SH01

    Cessazione della carica di Wayne Patrick Hellewell come amministratore in data 31 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Julian Harper come amministratore in data 31 ott 2014

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jog Dhody il 01 feb 2015

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 4Th Floor 32 Wigmore Street London W1U 2RP a 190 High Street Tonbridge Kent TN9 1BE in data 10 feb 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Lorraine Young Company Secretaries Limited come segretario in data 01 ott 2014

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Prism Cosec Limited come segretario in data 01 ott 2014

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di VANTAGE DISTRIBUTION LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LORRAINE YOUNG COMPANY SECRETARIES LIMITED
    6th Floor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Shakespeare Martineau Llp
    United Kingdom
    Segretario
    6th Floor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Shakespeare Martineau Llp
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione07873246
    165261700001
    DHODY, Jog
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Town Wall House
    Essex
    Amministratore
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Town Wall House
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant104269910005
    BRYANT, Adrian
    6 Pheasants Way
    WD3 2ES Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    6 Pheasants Way
    WD3 2ES Rickmansworth
    Hertfordshire
    British38711040002
    CHALK, Karen Jane
    49 Deerhurst Close
    TW13 7HS Feltham
    Middlesex
    Segretario
    49 Deerhurst Close
    TW13 7HS Feltham
    Middlesex
    British46464420002
    TEMPLE, John Nicholas
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    Segretario
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    British84493950001
    WEATHERALL, Sally
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    Segretario
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    152389680001
    PRISM COSEC LIMITED
    10 Margaret Street
    W1W 8RL London
    Prism Cosec
    United Kingdom
    Segretario
    10 Margaret Street
    W1W 8RL London
    Prism Cosec
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05533248
    116519070002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BRYANT, Adrian
    6 Pheasants Way
    WD3 2ES Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Pheasants Way
    WD3 2ES Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant38711040002
    CROCKER, Arthur Rupert
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    Amministratore
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    EnglandBritishAccountant79797070001
    HARPER, Simon Julian
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Operating Officer108485480003
    HELLEWELL, Wayne Patrick
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishOperations Director Uk & Sweden185877540001
    KELHAM, David William
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector87146390001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishDirector87146390001
    LEE, Andrew Stephen
    Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director159105430001
    RAMIS, Hayrettin
    1 Park Gate Avenue
    EN4 0NN Hadley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Park Gate Avenue
    EN4 0NN Hadley Wood
    Hertfordshire
    BritishEngineer22403690003
    SHIELDS, Stephen Andrew
    32 The Broadway
    Thorp Bay
    SS1 3HJ Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    32 The Broadway
    Thorp Bay
    SS1 3HJ Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritishDirector107406090001
    STOKES, Gary Martin
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishChief Executive71396660002
    TANSINI, Sergio
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    ScotlandItalianManaging Director106858140001
    WILSON, Jeremy Michael Charles
    Hinchingbrooke
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    Amministratore
    Hinchingbrooke
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector151756520001
    WOODWARD, Kathleen
    Kaadan High Easter Road
    Leaden Roding
    CM6 1QF Dunmow
    Essex
    Amministratore
    Kaadan High Easter Road
    Leaden Roding
    CM6 1QF Dunmow
    Essex
    BritishDirector107405790001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    VANTAGE DISTRIBUTION LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    Creato il 04 gen 2013
    Consegnato il 09 gen 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 09 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal assignment of contract monies
    Creato il 21 dic 2012
    Consegnato il 03 gen 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any security party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under an agreement for the purchase of debts the benefit of all the other provisions of the contract and all securities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 03 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 mag 2011
    Consegnato il 20 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 20 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank Nv, as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 feb 2007
    Consegnato il 09 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank Nv as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 lug 2005
    Consegnato il 10 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 22 lug 2005
    Consegnato il 23 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 27 feb 2004
    Consegnato il 16 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or intec cellular services limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 feb 2004
    Consegnato il 16 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    VANTAGE DISTRIBUTION LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 set 2016Inizio della liquidazione
    17 mar 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Howard Toone
    Cvr Global Llp New Fetter Place West
    55 Fetter Lane
    EC4A 1AA London
    Praticante
    Cvr Global Llp New Fetter Place West
    55 Fetter Lane
    EC4A 1AA London
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Praticante
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0