VANTAGE DISTRIBUTION LTD
Panoramica
Nome della società | VANTAGE DISTRIBUTION LTD |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03314092 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di VANTAGE DISTRIBUTION LTD?
- Commercio all'ingrosso di apparecchi radiofonici, televisivi ed elettrodomestici (esclusi nastri magnetici, dischi, CD e videocassette e le apparecchiature per la loro riproduzione) (46439) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova VANTAGE DISTRIBUTION LTD?
Indirizzo della sede legale | Town Wall House Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Essex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di VANTAGE DISTRIBUTION LTD?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
REGENERSIS DISTRIBUTION LTD | 06 giu 2008 | 06 giu 2008 |
INTEC DISTRIBUTION LIMITED | 10 ago 1998 | 10 ago 1998 |
BETA BUSINESS LIMITED | 06 feb 1997 | 06 feb 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di VANTAGE DISTRIBUTION LTD?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per VANTAGE DISTRIBUTION LTD?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2017 | 13 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Lorraine Young Company Secretaries Limited il 22 dic 2016 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR United Kingdom a Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD in data 26 ott 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 190 High Street Tonbridge Kent TN9 1BE a 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR in data 02 set 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed regenersis distribution LTD\certificate issued on 24/03/16 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jog Dhody il 17 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jog Dhody il 23 giu 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2014 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Wayne Patrick Hellewell come amministratore in data 31 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Julian Harper come amministratore in data 31 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jog Dhody il 01 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 4Th Floor 32 Wigmore Street London W1U 2RP a 190 High Street Tonbridge Kent TN9 1BE in data 10 feb 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Lorraine Young Company Secretaries Limited come segretario in data 01 ott 2014 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Prism Cosec Limited come segretario in data 01 ott 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di VANTAGE DISTRIBUTION LTD?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORRAINE YOUNG COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | 6th Floor 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London Shakespeare Martineau Llp United Kingdom |
| 165261700001 | ||||||||||
DHODY, Jog | Amministratore | Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Town Wall House Essex | England | British | Chartered Accountant | 104269910005 | ||||||||
BRYANT, Adrian | Segretario | 6 Pheasants Way WD3 2ES Rickmansworth Hertfordshire | British | 38711040002 | ||||||||||
CHALK, Karen Jane | Segretario | 49 Deerhurst Close TW13 7HS Feltham Middlesex | British | 46464420002 | ||||||||||
TEMPLE, John Nicholas | Segretario | Windfalls Highfield Road West Moors BH22 0NA Ferndown Dorset | British | 84493950001 | ||||||||||
WEATHERALL, Sally | Segretario | 4 Elm Place Old Witney Road Eynsham OX29 4BD Witney Oxfordshire | 152389680001 | |||||||||||
PRISM COSEC LIMITED | Segretario | 10 Margaret Street W1W 8RL London Prism Cosec United Kingdom |
| 116519070002 | ||||||||||
TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||||||
BRYANT, Adrian | Amministratore | 6 Pheasants Way WD3 2ES Rickmansworth Hertfordshire | England | British | Accountant | 38711040002 | ||||||||
CROCKER, Arthur Rupert | Amministratore | 35 Palmerston Road Wimbledon SW19 1PG London | England | British | Accountant | 79797070001 | ||||||||
HARPER, Simon Julian | Amministratore | High Street TN9 1BE Tonbridge 190 Kent United Kingdom | England | British | Chief Operating Officer | 108485480003 | ||||||||
HELLEWELL, Wayne Patrick | Amministratore | High Street TN9 1BE Tonbridge 190 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Operations Director Uk & Sweden | 185877540001 | ||||||||
KELHAM, David William | Amministratore | 4 Elm Place Old Witney Road Eynsham OX29 4BD Witney Oxfordshire | England | British | Director | 87146390001 | ||||||||
KELHAM, David William | Amministratore | Chastilian Gough Road GU51 4LJ Fleet Hampshire | England | British | Director | 87146390001 | ||||||||
LEE, Andrew Stephen | Amministratore | Floor 32 Wigmore Street W1U 2RP London 4th United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 159105430001 | ||||||||
RAMIS, Hayrettin | Amministratore | 1 Park Gate Avenue EN4 0NN Hadley Wood Hertfordshire | British | Engineer | 22403690003 | |||||||||
SHIELDS, Stephen Andrew | Amministratore | 32 The Broadway Thorp Bay SS1 3HJ Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | Director | 107406090001 | ||||||||
STOKES, Gary Martin | Amministratore | 16a Fiery Hill Road Barnt Green B45 8LG Birmingham West Midlands | England | British | Chief Executive | 71396660002 | ||||||||
TANSINI, Sergio | Amministratore | 4 Elm Place Old Witney Road Eynsham OX29 4BD Witney Oxfordshire | Scotland | Italian | Managing Director | 106858140001 | ||||||||
WILSON, Jeremy Michael Charles | Amministratore | Hinchingbrooke Huntingdon PE29 6FN Cambridgeshire Kingfisher Way United Kingdom | England | British | Director | 151756520001 | ||||||||
WOODWARD, Kathleen | Amministratore | Kaadan High Easter Road Leaden Roding CM6 1QF Dunmow Essex | British | Director | 107405790001 | |||||||||
COMPANY DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
VANTAGE DISTRIBUTION LTD ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Fixed charge on non-vesting debts and floating charge | Creato il 04 gen 2013 Consegnato il 09 gen 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal assignment of contract monies | Creato il 21 dic 2012 Consegnato il 03 gen 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and any security party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Any credit balance due to the company under an agreement for the purchase of debts the benefit of all the other provisions of the contract and all securities see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 mag 2011 Consegnato il 20 mag 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 18 set 2007 Consegnato il 27 set 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 feb 2007 Consegnato il 09 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 lug 2005 Consegnato il 10 ago 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
All assets debenture | Creato il 22 lug 2005 Consegnato il 23 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 27 feb 2004 Consegnato il 16 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or intec cellular services limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 feb 2004 Consegnato il 16 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
VANTAGE DISTRIBUTION LTD ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0