LDC (KING STREET) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LDC (KING STREET) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03317697 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LDC (KING STREET) LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova LDC (KING STREET) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Core 40 St Thomas Street BS1 6JX Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LDC (KING STREET) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DIGITRUN LIMITED | 13 feb 1997 | 13 feb 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LDC (KING STREET) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LDC (KING STREET) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per LDC (KING STREET) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Christopher Allan come amministratore in data 20 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come amministratore in data 30 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 17 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 12 ott 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 09 set 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Reid come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 12 ott 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LDC (KING STREET) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Segretario | 40 St Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | British | 175753180001 | ||||||
| SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Amministratore | 40 St Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | United Kingdom | British | 175753180001 | |||||
| RANSOME, David Peter | Segretario | Silver Birches Stinchcombe Hill GL11 6AQ Dursley Gloucestershire | British | 67258390002 | ||||||
| REID, Andrew Donald | Segretario | 15 Cranbrook Road Redland BS6 7BJ Bristol | British | 67884910002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALLAN, Mark Christopher | Amministratore | 40 St Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | England | British | 74371010007 | |||||
| KURASH, Perry Ian | Amministratore | 46 Douglas Lane TW19 5NG Wraysbury Berkshire | British | 54965310001 | ||||||
| PORTER, Nicholas Anthony | Amministratore | Ridge House Horse Race Lane Failand BS8 3TX Bristol | British | 45837900004 | ||||||
| RANSOME, David Peter | Amministratore | Silver Birches Stinchcombe Hill GL11 6AQ Dursley Gloucestershire | England | British | 67258390002 | |||||
| WHATSON, Andrew James | Amministratore | 10 Chesham Road SK9 6HA Wilmslow Cheshire | England | British | 125195410001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
LDC (KING STREET) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 08 lug 1998 Consegnato il 15 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H block c telephone house queen charlotte street bristol t/n-BL52913 and the underleasehold insterest in the second and third floors of block c telephone house aforesaid including all fixtures and fittings fixed plant and machinery thereon (other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 08 lug 1998 Consegnato il 15 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of floating charge all the undertaking and assets of the company whatsever and wheresoever both present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Further charge | Creato il 01 mag 1998 Consegnato il 08 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £280,000 and interest at the rate specified in the principal charge dated 16 september 1997 and removal of the limit of £10,000 plus interest in relation to the floating charge contained therein | |
Brevi particolari The f/h property k/a block c telephone house queen charlotte street and l/h interest in second and third floors block c telephone house queen charlotte street bristol t/n's BL52913 and BL55211. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge and floating charge | Creato il 16 set 1997 Consegnato il 02 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £980,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed or otherwise (limited as to the floating charge hereinafter referred to to the sum of £10,000 plus interest thereon) | |
Brevi particolari F/H property k/a block c telephone house queen charlotte street bristol t/n BL52913, the second and third floors of block c telephone house aforesaid, floating charge including all the goodwill. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0