SIGNS AND LABELS LIMITED

SIGNS AND LABELS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSIGNS AND LABELS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03318384
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SIGNS AND LABELS LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova SIGNS AND LABELS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Douglas Bruce House
    Corrie Way
    SK6 2RR Bredbury Park Industrial Estate
    Bredbury Stockport
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SIGNS AND LABELS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SIGNS & LABELS GROUP LIMITED26 mar 199826 mar 1998
    MARPLACE (NUMBER 405) LIMITED14 feb 199714 feb 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di SIGNS AND LABELS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per SIGNS AND LABELS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:sos cert release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:Form 4.40 g g Bates ceasing to act
    1 pagineLIQ MISC

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order INSOLVENCY:Replacement of Liquidator p j Windatt Replaces gg Bates 15/12/2009
    13 pagineLIQ MISC OC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    9 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 apr 2008

    LRESSP

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 lug 2006

    21 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine88(2)R

    legacy

    2 pagine88(2)R

    legacy

    9 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 lug 2005

    23 pagineAA

    legacy

    1 pagine244

    legacy

    9 pagine363s

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Conv shares 27/06/05
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio consolidato redatto al 04 dic 2004

    27 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SIGNS AND LABELS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JACKSON, John Paul
    4 Knightwood Glade
    Chandlers Ford
    SO53 4JA Eastleigh
    Hampshire
    Segretario
    4 Knightwood Glade
    Chandlers Ford
    SO53 4JA Eastleigh
    Hampshire
    British122350180001
    FELMER, Thomas James
    Hilly Lane
    Saukville
    8821
    Wisconsine
    United States
    Amministratore
    Hilly Lane
    Saukville
    8821
    Wisconsine
    United States
    United States Of AmericaAmerican128854080001
    JAEHNERT, Frank Michael
    W68n1068 Kensington Avenue
    53012 Cedarburg
    Wisconsin
    Usa
    Amministratore
    W68n1068 Kensington Avenue
    53012 Cedarburg
    Wisconsin
    Usa
    United States Of AmericaUsa68305240001
    SEPHTON, Peter Charles
    The Coach House
    Severnstoke Bank
    WR8 9JG Severnstoke
    Worcestershire
    Amministratore
    The Coach House
    Severnstoke Bank
    WR8 9JG Severnstoke
    Worcestershire
    United KingdomBritish59319040003
    WALSHAM, Andrew Stuart
    15 Elm Road
    SN7 7EJ Faringdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    15 Elm Road
    SN7 7EJ Faringdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish33682210002
    BRANDWOOD, Christopher Mark
    Oak House Oak Road
    Mottram St Andrew
    SK10 4RA Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    Oak House Oak Road
    Mottram St Andrew
    SK10 4RA Macclesfield
    Cheshire
    British46508870001
    HIGHAM, Maria Gabrielle
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    Segretario
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    British56630460001
    ASHLEY, Desmond Owen
    Holly Barn Holly Tree Walk
    Claybrooke Magna
    LE17 5DZ Lutterworth
    Leicestershire
    Amministratore
    Holly Barn Holly Tree Walk
    Claybrooke Magna
    LE17 5DZ Lutterworth
    Leicestershire
    EnglandUnited Kingdom53386540002
    FITZGERALD, David Sean
    1 Greenmount Gardens
    Greenmount
    BL8 4HN Bury
    Lancashire
    Amministratore
    1 Greenmount Gardens
    Greenmount
    BL8 4HN Bury
    Lancashire
    British61196400001
    HIGHAM, Maria Gabrielle
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    Amministratore
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    British56630460001
    HYAMS, Anthony Michael
    8 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    8 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    British56167340004
    MACDONALD, Iain Archibald
    7 Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    Amministratore
    7 Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    ScotlandBritish3614100004
    MATHIESON, David
    10920 North Elizabeth Court
    Mequon
    Wisconsin 53097
    Usa
    Amministratore
    10920 North Elizabeth Court
    Mequon
    Wisconsin 53097
    Usa
    British106586110001
    PADBERG, Mark Walter
    Thatchways
    Knobfield
    RH5 6RJ Abinger Hamer
    Surrey
    Amministratore
    Thatchways
    Knobfield
    RH5 6RJ Abinger Hamer
    Surrey
    British89261420001
    ROCHE, Susan Louise
    Rose Farm
    Astley Moss
    M29 7LX Manchester
    Amministratore
    Rose Farm
    Astley Moss
    M29 7LX Manchester
    Usa96243330001
    SCHOLES, Jeremy Hacking
    11 Gleneagles Drive
    Brockhall Village
    BB6 8BF Old Langho
    Lancashire
    Amministratore
    11 Gleneagles Drive
    Brockhall Village
    BB6 8BF Old Langho
    Lancashire
    EnglandBritish108377220001
    STOREY, Richard George
    49 Kennerley Road
    SK2 6EU Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    49 Kennerley Road
    SK2 6EU Stockport
    Cheshire
    British11628330002

    SIGNS AND LABELS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 08 dic 2003
    Consegnato il 09 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as signs and labels group limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 09 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 07 ott 2002
    Acquisito il 28 nov 2003
    Consegnato il 22 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Policy number jlt 18433 dated 8 may 2002 for £250,000 over the life of maria gabrielle higham. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2003Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 10 mag 2002
    Acquisito il 28 nov 2003
    Consegnato il 22 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 22 dic 2003Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 21 ott 1997
    Acquisito il 28 nov 2003
    Consegnato il 22 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Policy number RNF000401 52A with sun alliance and london insurance company limited in the life of richard storey. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2003Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 lug 1997
    Acquisito il 26 nov 2003
    Consegnato il 22 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2003Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 lug 1997
    Consegnato il 16 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SIGNS AND LABELS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 apr 2010Data di scioglimento
    23 apr 2008Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter John Windatt
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes
    Praticante
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes
    Gavin Geoffrey Bates
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes
    Praticante
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0