BRE VENTURES LIMITED

BRE VENTURES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRE VENTURES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03319327
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRE VENTURES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BRE VENTURES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bucknalls Lane
    Garston
    WD25 9XX Watford
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRE VENTURES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRE (CARDINGTON) LIMITED21 mar 199721 mar 1997
    MACROWORD LIMITED17 feb 199717 feb 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRE VENTURES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per BRE VENTURES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2018

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Jatinder Kaur Brainch come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 gen 2018 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    2 pagineAA

    Nomina di Ms Jatinder Kaur Brainch come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Guy Philip Hammersley come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 feb 2016

    Stato del capitale al 26 feb 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Niall Gerrard Trafford come amministratore in data 24 feb 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Russell Heusch come amministratore in data 24 feb 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mar 2015

    Stato del capitale al 16 mar 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mar 2014

    Stato del capitale al 21 mar 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Martin Wyatt come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BRE VENTURES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TRAFFORD, Niall Gerard
    Bucknalls Lane
    Garston
    WD25 9XX Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Bucknalls Lane
    Garston
    WD25 9XX Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish178888070001
    HORAN, James Francis
    1 Westmoreland Place
    Ealing
    W5 1QE London
    Segretario
    1 Westmoreland Place
    Ealing
    W5 1QE London
    British41588870001
    MEHTA, Suhrud Prakash
    108 Biddulph Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1HU London
    Segretario
    108 Biddulph Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1HU London
    British57444570001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRAINCH, Jatinder Kaur
    Bucknalls Lane
    WD25 9XX Watford
    Building Research Establishment Ltd
    England
    Amministratore
    Bucknalls Lane
    WD25 9XX Watford
    Building Research Establishment Ltd
    England
    EnglandBritish209134300001
    COURTNEY, Roger Graham
    89 Parkside Drive
    WD17 3AY Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    89 Parkside Drive
    WD17 3AY Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish81009310001
    HAMMERSLEY, Guy Philip
    Holts Meadow
    AL3 7BW Redbourn
    6
    Herts
    Amministratore
    Holts Meadow
    AL3 7BW Redbourn
    6
    Herts
    EnglandBritish131224250001
    HEUSCH, Russell
    Tenby Avenue
    HA3 8RX Harrow
    58
    Middlesex
    Amministratore
    Tenby Avenue
    HA3 8RX Harrow
    58
    Middlesex
    United KingdomBritish133476730001
    HORAN, James Francis
    1 Westmoreland Place
    Ealing
    W5 1QE London
    Amministratore
    1 Westmoreland Place
    Ealing
    W5 1QE London
    United KingdomBritish41588870001
    JACKSON, Rachel Hughlings
    31a Offord Road
    N1 1EA London
    Amministratore
    31a Offord Road
    N1 1EA London
    New Zealander51905730001
    MACFADYEN, Neil
    39 Lancaster Road
    W11 1QJ London
    Amministratore
    39 Lancaster Road
    W11 1QJ London
    United KingdomBritish74569730002
    MEHTA, Suhrud Prakash
    108 Biddulph Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1HU London
    Amministratore
    108 Biddulph Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1HU London
    British57444570001
    SHAW, Martin
    Oakfield 58a Horn Hill
    SG4 8AR Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    Oakfield 58a Horn Hill
    SG4 8AR Hitchin
    Hertfordshire
    British52180200003
    WYATT, Martin John, Dr
    The Birches
    School Lane
    AL9 6HD Essendon
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Birches
    School Lane
    AL9 6HD Essendon
    Hertfordshire
    EnglandBritish6078290006
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BRE VENTURES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bucknalls Lane
    WD25 9XX Watford
    B16
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Bucknalls Lane
    WD25 9XX Watford
    B16
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Ltd Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03319324
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BRE VENTURES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of covenant
    Creato il 17 dic 1997
    Consegnato il 19 dic 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of the deed
    Brevi particolari
    Land at cardington in the parish of eastcots in the county of bedfordshire having an area of 8.073 hectares(19.95 Acres) or thereabouts known as hangar 2.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Defence
    Transazioni
    • 19 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental I.P. charge
    Creato il 19 mar 1997
    Consegnato il 25 mar 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as macroword limited) and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever supplemental to the guarantee and debenture
    Brevi particolari
    All and any of the intellectual property, agreements and other rights, causes of action, interests and matters, know how as defined therein.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee and debenture
    Creato il 19 mar 1997
    Consegnato il 25 mar 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as macroword limited) and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under and as defined in "the debenture"
    Brevi particolari
    Freehold hangar no 2 raf cardington bedford bedfordshire, freehold land at princes risborough wickham buckinghamshire, freehold land known as site of the building research establishment garston st albans hertfordshire.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee and debenture
    Creato il 19 mar 1997
    Consegnato il 26 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as macroword limited) and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Murray Ventures PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0