ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03324967 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Bridgeway House Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Warwickshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MORETHANHOTELS (STAFFORD) LIMITED | 25 nov 2005 | 25 nov 2005 |
| FOREMOST HOTELS (STAFFORD) LIMITED | 30 mag 2003 | 30 mag 2003 |
| INGRAM (STAFFORD) LIMITED | 09 lug 1998 | 09 lug 1998 |
| ROADCHEF (STAFFORD) LIMITED | 23 apr 1997 | 23 apr 1997 |
| BEALAW (430) LIMITED | 27 feb 1997 | 27 feb 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione di Atlas Hotels (Group 4 Property 2) Limited come persona con controllo significativo il 12 dic 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di London and Regional Group Hotel Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 12 dic 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Adrian Paul Bradley come amministratore in data 19 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2018 al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Keith Ian Griffiths come amministratore in data 05 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sean Joseph Lowe come amministratore in data 05 gen 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 033249670006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da No.1 London Bridge London SE1 9BG England a Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 dic 2016 al 30 set 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 033249670005 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 18 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 033249670006, creata il 21 giu 2016 | 89 pagine | MR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 17 Dominion Street London EC2M 2EF a Bridgeway House Bridgeway Stratford-upon-Avon Warwickshire CV37 6YX in data 29 giu 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Shaun Robinson come amministratore in data 21 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADLEY, Adrian Paul | Amministratore | Baker Street W1U 8EW London 55 United Kingdom | United Kingdom | British | 90379240002 | |||||
| LOWE, Sean Joseph | Amministratore | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 195752560001 | |||||
| INGRAM HILL, Sarah | Segretario | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 59327230001 | ||||||
| MCCOLL, Fraser Robert | Segretario | Broom Cottage 1 Lodge Lane TN16 1RH Westerham Kent | British | 70649620002 | ||||||
| PENDRILL, Richard William | Segretario | Boscobel Sweetwater Lane Wormley GU8 5SS Godalming Surrey | British | 5919770001 | ||||||
| WARWICK, Timothy James | Segretario | Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno St Fagans CF5 4PJ Cardiff Wales | British | 65745040001 | ||||||
| BEACH SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 900002710001 | |||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Segretario | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||
| BARNES, Robert Digby Phillips | Amministratore | Brampton Chase Summerhouse Road GU7 1PY Godalming Surrey | United Kingdom | British | 59539070002 | |||||
| BELL, Alastair Marshall | Amministratore | 8 Thackeray Close Wimbledon SW19 4JL London | England | British | 87778630001 | |||||
| COUTURIER, Philippe | Amministratore | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | England | French | 185748330001 | |||||
| DARLING, Mervyn | Amministratore | St James's House Charlotte Street M1 4DZ Manchester Allied Irish Bank United Kingdom | United Kingdom | Irish | 147824160001 | |||||
| DE BURETEL DE CHASSEY, Marc Frederic Marie | Amministratore | 19 Furlong Road N7 8LS London | French | 110966050002 | ||||||
| DESSOKY, Usama | Amministratore | 5 Rudgwick Terrace 20 Avenue Road NW8 6BR London | England | British | 85181940001 | |||||
| DODD, Angus Alexander | Amministratore | 13 Redgrave Road SW15 1PX London | British | 110965490001 | ||||||
| DUNN, Barrie | Amministratore | B316 Peninsula Apartments 4 Praed Street W2 1JE London | United Kingdom | British | 109512300001 | |||||
| EDDIS, Christopher Frederick | Amministratore | 102 Portland Road Holland Park W11 4LX London | United Kingdom | British | 59311260003 | |||||
| GILLESPIE, Brendan | Amministratore | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office United Kingdom | British | 129902710001 | ||||||
| GRAUERS, Clifford Eric | Amministratore | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office United Kingdom | England | British | 60557140001 | |||||
| GRAY, Robert Edward | Amministratore | Dominion Street EC2M 2EF London 17 | United Kingdom | British | 188584900001 | |||||
| GRIFFITHS, Keith Ian | Amministratore | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 77782610002 | |||||
| HILL, Timothy Ingram | Amministratore | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 57283990001 | ||||||
| HORTHY, Sharif Istvan | Amministratore | 43 St Annes Crescent BN7 1SD Lewes East Sussex | England | British | 59598440001 | |||||
| INGRAM HILL, Sarah | Amministratore | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 59327230001 | ||||||
| KINGSMILL, Robert Martin | Amministratore | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office | United Kingdom | British | 139337530001 | |||||
| MCKEVITT, Richard | Amministratore | Nightingales Lane HP8 4SF Chalfont St. Giles Tyhurst Buckinghamshire | United Kingdom | British | 142295770001 | |||||
| MERCHANT, David John | Amministratore | 9 Fairmile Court KT11 2DS Cobham Surrey | England | British | 102844250001 | |||||
| MITCHELL, Stephen David | Amministratore | Great Portland Street W1W 5LS London 179 | England | British | 95336510001 | |||||
| MORAR, Neal | Amministratore | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | England | British | 173110500001 | |||||
| MYERS, David Paul | Amministratore | Great Portland Street W1W 5LS London 179 England | England | British | 142171370001 | |||||
| NOBLE, David | Amministratore | Great Portland Street W1W 5LS London 179-185 | England | British | 127359410001 | |||||
| ROBINSON, Shaun | Amministratore | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 101627760001 | |||||
| STOCKTON, Richard | Amministratore | Dominion Street EC2M 2EF London 17 | United Kingdom | British | 173676030001 | |||||
| WHITBY, Peter James | Amministratore | Great Portland Street W1W 5LS London 179-185 | England | English | 76096790002 | |||||
| CROFT NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 900002700001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London And Regional Group Hotel Holdings Ltd | 12 dic 2019 | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Atlas Hotels (Group 4 Property 2) Limited | 06 apr 2016 | Dominion Street EC2M 2EF London 17 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 21 giu 2016 Consegnato il 30 giu 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione The freehold and leasehold interests in holiday inn express stafford, stafford south, acton court, acton gate, stafford, ST18 9AP with title numbers SF384424 and SF381471 and SF525024 and, where the context so requires, includes the buildings on the property. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 17 dic 2014 Consegnato il 19 dic 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 ott 2007 Consegnato il 19 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The properties listed in schedule 2 of T. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 nov 2005 Consegnato il 05 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land lying on the west side of redbridge lane mursling southampton t/no HP581790,land lying to the north of hyde road gorton manchester t/no GM821643,land at harbledown canterbury t/no K787140 (for details of further properties charged plea. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 mag 2003 Consegnato il 13 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from ingram hotels limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h property k/a express by holiday inn stafford south acton court acton gate stafford t/n SF381471 together with the f/h land lying to the west of stafford road acton gate t/n SF384424. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 08 mag 2003 Consegnato il 13 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0