BLU INVESTMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BLU INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03325064 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BLU INVESTMENTS LIMITED?
- (7011) /
Dove si trova BLU INVESTMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BLU INVESTMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PCO 169 LIMITED | 21 feb 1997 | 21 feb 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BLU INVESTMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2007 |
Quali sono le ultime deposizioni per BLU INVESTMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
legacy | 1 pagine | 652a | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 403a | ||
legacy | 1 pagine | 403a | ||
legacy | 1 pagine | 403a | ||
legacy | 1 pagine | 403a | ||
legacy | 1 pagine | 403a | ||
legacy | 6 pagine | 363a | ||
legacy | 1 pagine | 353 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2007 | 19 pagine | AA | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
Chi sono gli amministratori di BLU INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAINE, Anthony | Segretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||
| PAILEX CORPORATE SERVICES LIMITED | Segretario nominato | First Floor Bouverie House 154 Fleet Street EC4A 2DQ London | 900013000001 | |||||||
| ADAM, Shenol | Amministratore | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | 2068480001 | ||||||
| BARNES, Eric Malcolm | Amministratore | 148 Chapel Lane Ravenshead NG15 9DJ Nottingham Nottinghamshire | British | 20256100002 | ||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||
| BRAINE, Anthony | Amministratore | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||
| BURY, David Gordon | Amministratore | The Viking Wing Thurland Castle Tunstall LA6 2QR Lancaster Lancashire | United Kingdom | British | 114282510002 | |||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||
| GUNSTON, Michael Ian | Amministratore | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | 3079890002 | |||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||
| HINCHLEY, David | Amministratore | 20 Leconfield Garth Follifoot HG3 1NF Harrogate North Yorkshire | British | 21091680001 | ||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||
| METLISS, Cyril | Amministratore | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||
| MORRIS, David | Amministratore | 4 Greenmount Drive Greenmount BL8 4HA Bury Lancashire | British | 3442030001 | ||||||
| PELTZ, Daniel | Amministratore | 9 Cavendish Avenue St Johns Wood NW8 9JD London | England | British | 34366280004 | |||||
| RITBLAT, John, Sir | Amministratore | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | 41694870001 | |||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Amministratore | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Amministratore | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||
| ROBERTS, Graham Charles | Amministratore | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 | |||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | United Kingdom | British | 63986410003 | |||||
| ROSEFIELD, Stephen Michael | Amministratore | 154 Fleet Street 1st Floor, Bouverie House EC4A 2DQ London | British | 51560380002 | ||||||
| TYLER, David Alan | Amministratore | 6 Ernle Road Wimbledon SW20 0HJ London | British | 51860290001 | ||||||
| WEBB, Nigel Mark | Amministratore | Beech Lodge 53 Crouch Hall Lane Redbourn AL3 7EU St Albans Hertfordshire | England | British | 58059360001 | |||||
| WESTON SMITH, John Harry | Amministratore | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | 13547380001 |
BLU INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Third supplemental trust deed supplemental to a trust deed dated 31 march 1998 (the principal trust deed),as defined,and securing the £100,000,000 6 > per cent.first mortgage debenture bonds 2011 and £200,000,000 6 > per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 of the company (the bonds) and the first supplemental trust deed dated 13 april 1999 (as defined) | Creato il 30 mar 2001 Consegnato il 10 apr 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment of the principal of,premium (if any) and all other moneys due or to become due from bl universal PLC to the chargee under or pursuant to the trust deed | |
Brevi particolari All rights,title and interest in the leasehold and freehold premises known as (I) 23/25 english st,carlisle; (ii) 35 high st,chelmsford; (iii) 41 oxford st,kidderminster plus other properties listed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 18 nov 1998 Consegnato il 04 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment of the principal of,premium (if any) and interest on the bonds,and any further bonds and all other moneys covenanted to be paid by bl universal PLC to the chargee under or pursuant to the trust deed | |
Brevi particolari The premises at 20 donegall place,belfast comprised in and held under lease dated 1 august 1929. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 19 mag 1998 Consegnato il 21 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment of the principal of premium (if any) and interest on the original bonds (as defined) and all further bonds (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the mortgage | |
Brevi particolari F/H premises comprising part of the arches retail park connswater belfast; l/h premises forming part of the arches retail park connswater belfast; l/h premises situate at albertbridge road belfast. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage in relation to a trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 (with authority to issue further first mortgage debenture bonds or notes) (the bonds) | Creato il 31 mar 1998 Consegnato il 18 apr 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment of the principal of, premium (if any) and interest on the original bonds and all further bonds and all other moneys covenanted to be paid by the company to the chargee (the trustee) under or pursuant to the mortgage | |
Brevi particolari F/H and l/h premises k/a connswater shopping centre belfast. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 (with authority to issue further first mortgage debenture bonds or notes) | Creato il 31 mar 1998 Consegnato il 16 apr 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment of the principal of, the premium (if any) and interest on the bonds and all other moneys covenanted to be paid by bl universal PLC to the trustee under or pursuant to the trust deed | |
Brevi particolari Various properties as specified on form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0