ABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED

ABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03325272
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED?

    • Attività ospedaliere (86101) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova ABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 1st Floor
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INHOCO 588 LIMITED27 feb 199727 feb 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Bmi Healthcare House 3 Paris Garden Southwark London SE1 8nd a 30 1st Floor 30 Cannon Street London EC4M 6YN in data 30 mag 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Catherine Vickery come segretario in data 30 nov 2018

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Karen Anita Prins il 09 nov 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Catherine Mary Jane Vickery come amministratore in data 30 nov 2018

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2017 al 31 mar 2018

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Karen Anita Prins il 14 mar 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Dr Karen Anita Prins come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jill Margaret Watts come amministratore in data 30 set 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mar 2016

    Stato del capitale al 07 mar 2016

    • Capitale: GBP .1
    SH01

    Nomina di Henry Jonathan Davies come amministratore in data 01 set 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Catherine Mary Jane Vickery come amministratore in data 01 mag 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Craig Barry Lovelace come amministratore in data 30 apr 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 apr 2015

    Stato del capitale al 01 apr 2015

    • Capitale: GBP .1
    SH01

    Nomina di Jill Margaret Watts come amministratore in data 17 nov 2014

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Henry Jonathan
    1st Floor
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    30
    England
    Amministratore
    1st Floor
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    30
    England
    EnglandBritishFinance Director201206200001
    PRINS, Karen Anita, Dr
    1st Floor
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    30
    England
    Amministratore
    1st Floor
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    30
    England
    EnglandSouth AfricanChief Executive Officer238969330004
    DAY, Jonathan
    19 Kenwood Road
    Highgate
    N6 4EA London
    Segretario
    19 Kenwood Road
    Highgate
    N6 4EA London
    BritishSolicitor122061300001
    RICHARDSON, Ian Ashley
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    Segretario
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    British66535330002
    VICKERY, Catherine
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    Segretario
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    160052710001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    AINLEY, Harvey Bertenshaw
    Priory Road
    SL5 8EB Ascot
    Orchard House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Priory Road
    SL5 8EB Ascot
    Orchard House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant134262810002
    BUCKLEY, Fiona Marie
    Browning House
    14 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    Browning House
    14 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant61688100004
    COLLIER, Stephen John
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    Amministratore
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    United KingdomBritishDirector18350160001
    GOODWIN, Philip Walter
    5 Farmer Street
    Notting Hill
    W8 7SN London
    Amministratore
    5 Farmer Street
    Notting Hill
    W8 7SN London
    BritishInvestment Banker72752130001
    HEMMING, Eric Rodney
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    Amministratore
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    BritishOperations Director84030950001
    INCHLEY, Simon
    10 Fletcher Drive
    WA14 3FZ Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    10 Fletcher Drive
    WA14 3FZ Bowdon
    Cheshire
    BritishInvestment Banker64345880001
    ISHAK HANNA, Magdy Adib, Dr
    Eliot House
    40 Bishops Avenue Hampstead
    N2 0BA London
    Amministratore
    Eliot House
    40 Bishops Avenue Hampstead
    N2 0BA London
    EnglandBritishDirector76628190003
    LOVELACE, Craig Barry
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    Amministratore
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant198852370001
    RAMSAY, James
    The Old Post Office
    Village Road Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Post Office
    Village Road Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    BritishDirector40105120004
    RICHARDSON, Ian Ashley
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    Amministratore
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor66535330002
    ROBERTSON, Nigel Mark Inches
    Sopworth
    SN14 6PT Chippenham
    Wookeys Barn
    Wiltshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sopworth
    SN14 6PT Chippenham
    Wookeys Barn
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector97170790002
    RODDIS, Simon James Edward
    23a Mauldeth Road
    SK4 3NE Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    23a Mauldeth Road
    SK4 3NE Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Accountant62717920002
    SMITH, Michael John
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    Amministratore
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    EnglandBritishCompany Director641150001
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    Amministratore
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United KingdomBritishGeneral Counsel & Company Secretary102009810003
    WATTS, Jill Margaret
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    Amministratore
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    EnglandBritishGroup Chief Executive187252950001
    WIELAND, Phil
    Thameside Centre
    Kew Bridge Road
    TW8 0HF Brentford
    4
    Middlesex
    Amministratore
    Thameside Centre
    Kew Bridge Road
    TW8 0HF Brentford
    4
    Middlesex
    United KingdomBritishFinance Director119448000002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Abbey Hospitals Run Off Limited
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    06 apr 2016
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies For England And Wales
    Numero di registrazione05706208
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ABBEY HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 apr 2005
    Consegnato il 29 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ) as Security Trustee for the Secured Parties)(In Such Capacity the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 29 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 giu 2002
    Consegnato il 05 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Shares mortgage
    Creato il 24 gen 2002
    Consegnato il 01 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The original securities; all rights moneys (including without limitation dividends) and property whatsoever which may from time to time at any time be derived from accrue on or be offered in respect of the original securities,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 01 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Shares mortgage
    Creato il 22 gen 2002
    Consegnato il 01 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The original securities; all rights moneys (including without limitation dividends) and property whatsoever which may from time to time at any time be derived from accrue on or be offered in respect of the original securities,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 01 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 gen 2002
    Consegnato il 01 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 01 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 30 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of the loan notes (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equity Limited,as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 30 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 13 mag 1997
    Consegnato il 02 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as inhoco 588 limited) and/or all or any "group company"(as defined in the assignment) to the chargee under the terms of the facility documents (as defined) and this charge
    Brevi particolari
    All right title and interest of the company in and to the policy of insurance held by the company with guardian financial services policy number L010 470 3660 in respect of the life of eric rodney hemming together with ny substitution or replacement thereof and all benefit and monies payable therefrom.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 09 mag 1997
    Consegnato il 13 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly k/a inhoco 588 limited) to the chargees on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the policy of insurance no.l/01/04703660D dated 9TH may 1997 on the life of eric rodney hemming including all policies replacing thereof and all related rights thereto inclusive of bonuses. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Esbc Equity Limited(The Security Agent)
    Transazioni
    • 13 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 mar 1997
    Consegnato il 14 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company as defined to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 mar 1997
    Consegnato il 11 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees in respect of the loan notes and this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 11 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0