GWK AMTEK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGWK AMTEK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03326288
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GWK AMTEK LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova GWK AMTEK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite 306 Third Floor Fort Dunlop
    Fort Parkway
    B24 9FD Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GWK AMTEK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GWK GROUP LIMITED01 mag 199701 mag 1997
    FORAY 1011 LIMITED28 feb 199728 feb 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di GWK AMTEK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per GWK AMTEK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 nov 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 26 nov 2009

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da King Automotive Systems Limited Chelmarsh Diamler Green Coventry CV6 3LT in data 11 nov 2009

    2 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per John Ernest Flintham il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Phillipa Lucy Bishop il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Arvind Dham il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    18 pagine395

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GWK AMTEK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BISHOP, Phillipa Lucy
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    Segretario
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    BritishCompany Secretary101086280001
    DHAM, Arvind
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    Amministratore
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    IndiaIndianDirector93665890001
    FLINTHAM, John Ernest
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    Amministratore
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    United KingdomBritishDirector36461330002
    DAVIDSON, Alan Neil Ramsay, Captain
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    Segretario
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    BritishChairman63313000002
    DRURY, Richard Anthony
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    Segretario
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    BritishFinance Director15235520001
    HYLAND, Matthew William Edward
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor43019310004
    PAUL, Peter Michael
    Keys Cottage
    School Lane Warmington
    OX17 1DE Banbury
    Oxon
    Segretario
    Keys Cottage
    School Lane Warmington
    OX17 1DE Banbury
    Oxon
    British7677600001
    BENTON, Derek John
    Bridge House Bradnocks Marsh Lane
    Hampton In Arden
    B92 0LL Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Bridge House Bradnocks Marsh Lane
    Hampton In Arden
    B92 0LL Solihull
    West Midlands
    EnglandEnglishFinance Director38163810002
    CHURCHMAN, Richard Alan
    The Garden Flat
    43 Abbey Road St Johns Wood
    NW8 0AA London
    Amministratore
    The Garden Flat
    43 Abbey Road St Johns Wood
    NW8 0AA London
    EnglandBritishDirector37813980001
    DAVIDSON, Alan Neil Ramsay, Captain
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    Amministratore
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    United KingdomBritishChairman63313000002
    DRURY, Richard Anthony
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    Amministratore
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    BritishFinance Director15235520001
    FISHER, Jacqueline
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    BritishSecretary44103090001
    HYLAND, Matthew William Edward
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor43019310004
    PARKER, Kenneth
    The Holt 5 Kingfisher Way
    Sheepy Parva
    CV9 3SW Atherstone
    Leicestershire
    Amministratore
    The Holt 5 Kingfisher Way
    Sheepy Parva
    CV9 3SW Atherstone
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director83139010002
    PAUL, Peter Michael, Director
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    BritishDirector7677600002
    SMITH, Philip Anthony
    7 Graeme Road
    Sutton
    PE5 7XE Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    7 Graeme Road
    Sutton
    PE5 7XE Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director117160910001
    SYAL, Ashwini Kumar
    Block A 90 Grd Floor
    South City
    Gurgaon
    Haryana 122001
    India
    Amministratore
    Block A 90 Grd Floor
    South City
    Gurgaon
    Haryana 122001
    India
    IndianSales Manager98849180001
    WELCH, Roderick Brett
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    Amministratore
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director90527220001
    WINTERBOTTOM, David Stuart
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    BritishChairman6529580001

    GWK AMTEK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 06 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ford Motor Company Limited
    Transazioni
    • 06 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment of life policy
    Creato il 01 nov 2004
    Consegnato il 02 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy: name of insurer: scottish equitable PLC policy number: LO197882942 name of life assured: alan neil ramsay davidson and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 01 nov 2004
    Consegnato il 02 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy: name of insurer: scottish equitable PLC policy number: LO198092942 name of life assured: richard churchman and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 01 nov 2004
    Consegnato il 02 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy: name of insurer: scottish equitable PLC policy number: LO193682942 name of life assured: ken parker and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 ott 2003
    Consegnato il 07 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 07 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 ott 2003
    Consegnato il 29 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 29 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 18 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 18 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 18 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all land now owned by the company including (without limitation) the properties being 25 year l/h interest in land and buildings on the north-west side of blackhorse road letchworth SG8 1EL t/n HD405547 and 25 year l/h interest in land and buildings lying to the east of capmartin road radford coventry CV6 3FX t/n WM763836. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 18 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 18 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all land now owned by the company including (without limitation) the properties being 25 year l/h interest in land and buildings on the north-west side of blackhorse road letchworth SG8 1EL t/n HD405547 and 25 year l/h interest in land and buildings lying to the east of capmartin road radford coventry CV6 3FX t/n WM763836. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mag 1997
    Consegnato il 14 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as foray 1011 limited) to the chargee under the facilities agreement and the debenture as defined therein
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mag 1997
    Consegnato il 14 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as foray 1011 limited) to the chargee under the facilities agreement and the debenture as defined therein
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mag 1997
    Consegnato il 07 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as foray 1011 limited) to the chargee in respect of the loan (as defined)
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC, for Itself and as Trustee for the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 07 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GWK AMTEK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 apr 2011Data di scioglimento
    26 nov 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Martin Frederick Peter Smith
    Suite 306 Third Floor
    Fort Dunlop
    B24 9FD Fort Parkway
    Birmingham
    Praticante
    Suite 306 Third Floor
    Fort Dunlop
    B24 9FD Fort Parkway
    Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0