CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03328039 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED?
- Attività ospedaliere (86101) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
- Attività di medicina specialistica (86220) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | John Webster House 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CENTRE FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED | 27 mar 1997 | 27 mar 1997 |
| FISHEL-DOWELL FERTILITY ASSOCIATES LIMITED | 05 mar 1997 | 05 mar 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 31 ago 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 14 set 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 31 ago 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2024 | 28 pagine | AA | ||
legacy | 51 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata John Webster House 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park Nottingham NG8 6PZ | 1 pagine | AD04 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor, 6 Bevis Marks London EC3A 7BA England a John Webster House 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park Nottingham NG8 6PZ | 1 pagine | AD02 | ||
Cessazione della carica di Alan Philip Clark come amministratore in data 28 ago 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Michael Ian Henry come amministratore in data 06 mag 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Grant House Bourges Boulevard Peterborough PE1 1NG England a John Webster House 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park Nottingham NG8 6PZ in data 29 apr 2025 | 1 pagine | AD01 | ||
Nomina di Mr Alan Philip Clark come amministratore in data 28 feb 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di David Brian Burford come amministratore in data 28 feb 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da John Webster House 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park Nottingham NG8 6PZ a Grant House Bourges Boulevard Peterborough PE1 1NG in data 11 mar 2025 | 1 pagine | AD01 | ||
Bilancio modificato di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2023 | 25 pagine | AAMD | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2023 | 25 pagine | AA | ||
legacy | 55 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2022 | 24 pagine | AA | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 51 pagine | PARENT_ACC | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Paul David Brame come amministratore in data 30 giu 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAME, Paul David | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House England | United Kingdom | British | 312342590001 | |||||
| HENRY, Michael Ian | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House England | United Kingdom | British | 335633760001 | |||||
| CLEMENT, Augustine Oluseyi | Segretario | 31 Genesta Road SE18 3ER London | British | 106953870002 | ||||||
| COLLIER, Stephen John | Segretario | 180 Kennington Park Road Kennington SE11 4BT London | British | 18350160001 | ||||||
| JOHNSON, Sian | Segretario | 2 Quernmore Road N4 4QU London | British | 53048070004 | ||||||
| SAUERMAN, Anthony | Segretario | 104 St Thomass Road Finsbury Park N4 2QW London | British | 52536680001 | ||||||
| VICKERY, Catherine Mary Jane | Segretario | Clarence Road SW19 8QD London 142 | British | 102009810002 | ||||||
| YOUNG, John Ditlev Christiani | Segretario | 10 Huntingdon Drive The Park NG7 1BW Nottingham | British | 39055180001 | ||||||
| AINLEY, Harvey Bertenshaw | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | United Kingdom | British | 193219010001 | |||||
| BRAME, Paul David | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | 257513990002 | |||||
| BURFORD, David Brian | Amministratore | Bourges Boulevard PE1 1NG Peterborough Grant House England | United Kingdom | British | 194714760002 | |||||
| CLARK, Alan Philip | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House England | England | British | 267730690001 | |||||
| COLLIER, Stephen John | Amministratore | 180 Kennington Park Road Kennington SE11 4BT London | United Kingdom | British | 18350160001 | |||||
| DENSEM, Nora June | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | Guernsey | British | 294216820001 | |||||
| DOWELL, Kenneth, Dr | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | 55004870001 | |||||
| FISHEL, Simon Brian, Professor | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | 54328790002 | |||||
| HAYES, Eugene Gerard | Amministratore | 42 West Heath Drive NW11 7QH London | Irish | 2464310004 | ||||||
| LOWRY, Nigel | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | 94983990002 | |||||
| MAIN, Iain James Robert | Amministratore | Hunter Court Bampton Road OX18 2RG Clanfield Oxfordshire | British | 43800760003 | ||||||
| MORRIS, Christine | Amministratore | 28 Stamford Road West Bridgford NG2 6GB Nottingham Nottinghamshire | British | 51645420001 | ||||||
| PARSONS, Michael Neil | Amministratore | 10 Whirlow Park Road S11 9NP Sheffield South Yorkshire | British | 44668390001 | ||||||
| PRESTON, Paul Richard, Dr | Amministratore | Foxholm 65 Lubbock Road BR7 5JG Chislehurst Kent | British | 51034310002 | ||||||
| ROBERTSON, Nigel Mark Inches | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | 192725620001 | |||||
| THOMSON, Ian Stewart | Amministratore | Church Lane Staverton GL51 0TW Cheltenham Brooklaines Farm Gloucestershire England | England | British | 158341000001 | |||||
| THORNTON, Simon | Amministratore | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | 54884040002 | |||||
| YOUNG, John Ditlev Christiani | Amministratore | 10 Huntingdon Drive The Park NG7 1BW Nottingham | British | 39055180001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Care Fertility Group Limited | 06 apr 2016 | 6 Lawrence Drive, Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0