MARCHPOLE HOLDINGS PLC

MARCHPOLE HOLDINGS PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARCHPOLE HOLDINGS PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03328638
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    • (5142) /

    Dove si trova MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    Indirizzo della sede legale
    c/o GRANT THORNTON LLP
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al05 apr 2008

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 24 ago 2011

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagineLQ02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 09 nov 2010

    2 pagine3.6

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 09 nov 2009

    2 pagine3.6

    Ordine del tribunale di liquidazione

    1 pagineCOCOMP

    Stato patrimoniale in amministrazione controllata a seguito della relazione ai creditori

    55 pagine3.3

    Relazione del commissario giudiziario amministrativo

    13 pagine3.10

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine403b

    legacy

    2 pagine403b

    legacy

    2 pagine403b

    legacy

    2 pagine403b

    legacy

    1 pagine405(1)

    Bilancio consolidato redatto al 05 apr 2008

    62 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company info 23/10/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine88(2)

    legacy

    2 pagine123

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di aumento del capitale sociale autorizzato

    RES04
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    legacy

    10 pagine363s
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    annual-return21 ago 2008

    legacy

    363(353)

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHULMAN, Harvey Barry
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Segretario
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    British1239130001
    HARRIS, Raymond Ian
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    Amministratore
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    United KingdomBritish91547170001
    LADOW, Allan
    Igelkottstigen 5
    Hovas
    43650
    Sweden
    Amministratore
    Igelkottstigen 5
    Hovas
    43650
    Sweden
    Swedish132918310001
    MOLLOY, John Patrick
    117 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    Amministratore
    117 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    EnglandBritish125361860001
    MORRIS, Michael Maurice
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    Amministratore
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    United KingdomBritish117529460001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    Amministratore
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    EnglandBritish46176700002
    SHULMAN, Harvey Barry
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Amministratore
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    EnglandBritish1239130001
    STIRLING, Ronald Edward
    The White Cottage
    21 Randolph Road
    W9 1AN London
    Amministratore
    The White Cottage
    21 Randolph Road
    W9 1AN London
    British20434210001
    BRADFIELD, David Warren
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    Segretario
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    British66000710004
    HAMPSHIRE, James Justin
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    Segretario
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    British83282010001
    KIERNAN, James Francis
    111 Telscombe Way
    LU2 8QP Sheldon
    Birmingham
    Segretario
    111 Telscombe Way
    LU2 8QP Sheldon
    Birmingham
    British87389050001
    TAHMASEBI, Khosrow
    The Paddocks
    3 Lavender Close
    CR3 5DW Chaldon Common
    Surrey
    Segretario
    The Paddocks
    3 Lavender Close
    CR3 5DW Chaldon Common
    Surrey
    British38518070001
    TAYLOR, Charles Robert
    77 Plover Way
    Surrey Quays
    SE16 7TS London
    Segretario
    77 Plover Way
    Surrey Quays
    SE16 7TS London
    British72657510001
    WIEDER, Robert
    185 Adelaide Road
    NW3 3NN London
    Segretario
    185 Adelaide Road
    NW3 3NN London
    British85513530001
    ALLNER, Christopher Charles
    Childs Farm
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Childs Farm
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish78206300001
    BIGNALL, John
    Mistletoe Farm
    Cuckoo Hill
    HA5 2BB Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    Mistletoe Farm
    Cuckoo Hill
    HA5 2BB Pinner
    Middlesex
    British907580001
    BOOTHMAN, Derek Arnold
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    British5733500001
    BRADFIELD, David Warren
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    Amministratore
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    British66000710004
    BUTLER, Roger John
    1a 14 Bramham Gardens
    SW5 0JJ London
    Amministratore
    1a 14 Bramham Gardens
    SW5 0JJ London
    British3453620004
    CAPLIN, Anthony Lindsay
    Elm Lodge
    River Gardens
    SW6 6NZ London
    22
    Amministratore
    Elm Lodge
    River Gardens
    SW6 6NZ London
    22
    United KingdomBritish139900020001
    COX, Andrew Douglas
    56 Centre Quay
    Burlington Road Port Marine
    BS20 7AX Portishead
    Avon
    Amministratore
    56 Centre Quay
    Burlington Road Port Marine
    BS20 7AX Portishead
    Avon
    British101923580001
    GILLIATT, John Mowbray
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    ScotlandBritish169894800001
    GRAY, Ian Archie
    6 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    Amministratore
    6 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    EnglandBritish115801110001
    HAMPSHIRE, James Justin
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    Amministratore
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    United KingdomBritish83282010001
    HARRISON, John
    Goodwin Manor
    Swaffham Prior
    CB5 0LG Cambridge
    Amministratore
    Goodwin Manor
    Swaffham Prior
    CB5 0LG Cambridge
    EnglandBritish104830840001
    JOHNSON, Adrian Robert Barnett
    5 Wilberforce Way
    Lauriston Road Wimbledon Common
    SW19 4TH London
    Amministratore
    5 Wilberforce Way
    Lauriston Road Wimbledon Common
    SW19 4TH London
    British57119570001
    KERR-MUIR, James Rodier
    Flat 8 71 Elm Park Gardens
    SW10 9QE London
    Amministratore
    Flat 8 71 Elm Park Gardens
    SW10 9QE London
    British37895700002
    MACAULAY, John Arnold
    51 Dove Park
    WD3 5NY Chorley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    51 Dove Park
    WD3 5NY Chorley Wood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish154398330001
    MATTEY, David Gary
    10 Royal Avenue
    SW3 4QF London
    Amministratore
    10 Royal Avenue
    SW3 4QF London
    EnglandBritish7199250004
    MELBOURN, John William
    4 Berkeley Gardens
    Claygate
    KT10 0TP Esher
    Surrey
    Amministratore
    4 Berkeley Gardens
    Claygate
    KT10 0TP Esher
    Surrey
    EnglandBritish6081080001
    MESSIK, John Charles
    Flat 1
    16 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NR London
    Amministratore
    Flat 1
    16 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NR London
    British41030750004
    MORRIS, Michael Maurice
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    Amministratore
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    United KingdomBritish117529460001
    MOSS, David Harry
    7 St Marys Grove
    SW13 0JA London
    Amministratore
    7 St Marys Grove
    SW13 0JA London
    United KingdomBritish93660650001
    REYNOLDS, Adam
    14 Charles Harrod Court
    Harrods Village
    SW13 8HH Barnes
    London
    Amministratore
    14 Charles Harrod Court
    Harrods Village
    SW13 8HH Barnes
    London
    United KingdomBritish85661680003
    SANTELL, Hilary Anne
    The Stables Mountains
    Noble Tree Road
    TN11 8ND Hildenborough
    Kent
    Amministratore
    The Stables Mountains
    Noble Tree Road
    TN11 8ND Hildenborough
    Kent
    British66561080002

    MARCHPOLE HOLDINGS PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 ago 2008
    Consegnato il 19 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Atlas
    Transazioni
    • 19 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Pledge of quota
    Creato il 24 mar 2006
    Consegnato il 11 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Pledge over all quota owned by the company in J.C.de castelbajac italy srl and any rights attached to that quota.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Agreement for the pledge of account of financial instruments relating to shares of jean-charles de castelbajac S.A.
    Creato il 21 mar 2006
    Consegnato il 24 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Pledge over all shares and financial instruments owned by the company in jean-charles de castelbajac S.A. and any rights attached to those shares and financial instruments.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Pledge agreement
    Creato il 07 mar 2006
    Consegnato il 17 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Pledge over all membership interests owned by the company in moda america llc and any rights attached to those membership interests.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over shares in marchpole hong kong limited
    Creato il 07 mar 2006
    Consegnato il 17 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge over all shares owned by the company in marchpole hong kong limited and any rights attached to those shares.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over shares in J.c de castelbajac hong kong limited
    Creato il 07 mar 2006
    Consegnato il 17 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge over all shares owned by the company in J.c de castelbajac hong kong limited and any rights attached to those shares.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 29 lug 2002
    Consegnato il 31 lug 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 05 gen 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 122 lug 2011Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 1
    Debenture
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 22 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £250,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the entire business and assets of marchpole holdings PLC.
    Persone aventi diritto
    • Downash Consulting Limited
    Transazioni
    • 22 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 11 set 2000
    Consegnato il 19 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over book debts
    Creato il 06 giu 2000
    Consegnato il 26 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 mag 1998
    Consegnato il 15 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 19/20 berners street london W1 t/n NGL724255. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to deed of assignment of life policy
    Creato il 26 set 1997
    Consegnato il 16 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All amounts of principal interest or otherwise and obligations which at any time after 5TH april 1997 may be due owing or incurred under the loan note instrument and the notes by the company to the noteholders (as defined) and/or the chargee (as trustee) up to but not exceeding £10,000 000 from 5TH april 1997 until and including 31ST march 1998 and up to but not exceeding £5,000,000 from 1ST april 1998 until and including 31ST march 1999
    Brevi particolari
    Policy number 24276-088-das and 24277-088-das on the life of michael morris in the sum of £5,000,000 and £5,000,000 with allied dunbar assurance PLC with all bonuses accrued.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Ventures (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 16 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of life policy
    Creato il 05 apr 1997
    Consegnato il 10 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument and the notes up to but not exceeding £10,000,000 from 5TH april 1997 until and including 31ST march 1998 and up to but not exceeding £5,000,000 from 1ST april 1998 until and including 31ST march 1999
    Brevi particolari
    With full title guarantee the policy and monies inlcuding bonuses on the life of michael morris policy number 24276-081-das & 24277-081-das for £5,000,000 and £5000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Ventures (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 10 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MARCHPOLE HOLDINGS PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Ricevitore amministrativo
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Ricevitore amministrativo
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DataTipo
    16 giu 2015Conclusione della liquidazione
    14 mag 2009Data della petizione
    01 lug 2009Inizio della liquidazione
    22 set 2015Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praticante
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0