WOLSELEY RAVEN LIMITED

WOLSELEY RAVEN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWOLSELEY RAVEN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03328667
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WOLSELEY RAVEN LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WOLSELEY RAVEN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WOLSELEY RAVEN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    UNIFIX LIMITED01 ott 199701 ott 1997
    LEVERPOST LIMITED06 mar 199706 mar 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di WOLSELEY RAVEN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WOLSELEY RAVEN LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WOLSELEY RAVEN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mar 2016

    Stato del capitale al 17 mar 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2015

    5 pagineAA

    Nomina di Katherine Mary Mccormick come segretario in data 31 lug 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Graham Middlemiss come segretario in data 31 lug 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mar 2015

    Stato del capitale al 17 mar 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Graham Middlemiss il 16 feb 2015

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2014

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Graham Middlemiss come amministratore in data 13 ago 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Ashmore come amministratore in data 31 lug 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Wolseley Uk Directors Limited come amministratore in data 31 lug 2014

    2 pagineAP02

    Cessazione della carica di Keith Harold Davenport Jones come amministratore in data 31 lug 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Marc Arthur Ronchetti come amministratore in data 31 lug 2014

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mar 2014

    Stato del capitale al 25 mar 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Derek Harding come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    pagineANNOTATION

    Nomina di Graham Middlemiss come segretario

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di WOLSELEY RAVEN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCORMICK, Katherine Mary
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Segretario
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    199926780001
    RONCHETTI, Marc Arthur
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    Amministratore
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    EnglandBritish247980780001
    WOLSELEY UK DIRECTORS LIMITED
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    Amministratore
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione09104902
    190186170001
    BROPHY, Tom
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    Segretario
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    162238770001
    CLAY, Richard William
    14 The Drive
    Roundhay
    LS8 1JF Leeds
    Segretario
    14 The Drive
    Roundhay
    LS8 1JF Leeds
    British9531240002
    DREW, Alison
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    Segretario
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    British86845230002
    MIDDLEMISS, Graham
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Segretario
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    174268140001
    TRENFIELD, Alison Jane
    Brackley 90 Main Road
    Baxterley
    CV9 2LE Atherstone
    Warwickshire
    Segretario
    Brackley 90 Main Road
    Baxterley
    CV9 2LE Atherstone
    Warwickshire
    British43478290001
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    Segretario
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    British82978250002
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Segretario nominato
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    ASHMORE, Stephen, Mr.
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish232880380001
    BOSTOCK, John Robert
    Lygon
    Boxtree Close
    WR8 9BX Defford
    Worcester
    Amministratore
    Lygon
    Boxtree Close
    WR8 9BX Defford
    Worcester
    British29274210001
    DALLY, Andrew
    36 Folley Road
    Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    36 Folley Road
    Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    West Midlands
    British68062140001
    FELSTEAD, Richard Arthur
    Orchard Hill Cottage
    Hillside Martley
    WR6 6QN Worcestershire
    Amministratore
    Orchard Hill Cottage
    Hillside Martley
    WR6 6QN Worcestershire
    EnglandBritish179460100001
    GLOVER, Francis Joseph David
    2 Velvet Stone Cottage Westwood Lane
    Hatfield
    HR6 0SQ Leominster
    Herefordshire
    Amministratore
    2 Velvet Stone Cottage Westwood Lane
    Hatfield
    HR6 0SQ Leominster
    Herefordshire
    United KingdomBritish48934180001
    HARDING, Derek John
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritish152377500001
    HAY, Alistair
    25 St Lukes Close
    WR11 6ET Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    25 St Lukes Close
    WR11 6ET Evesham
    Worcestershire
    British54861710001
    HAY, Alistair
    25 St Lukes Close
    WR11 6ET Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    25 St Lukes Close
    WR11 6ET Evesham
    Worcestershire
    British54861710001
    JONES, Keith Harold Davenport
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    P O Box 21
    Boroughbridge Road
    HG4 1SL Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish95915810001
    MIDDLEMISS, Graham
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish100701940002
    MILLMAN, Stephen John
    11 Alcester Drive
    B73 6PZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    11 Alcester Drive
    B73 6PZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish45272340001
    NEVILLE, Matthew James
    9 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    9 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish85093360003
    O'BRIEN, Alan
    48 Flambards Close
    Meldreth
    SG8 6JX Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    48 Flambards Close
    Meldreth
    SG8 6JX Royston
    Hertfordshire
    British59236230001
    TILLOTSON, Ian
    The Ashes
    16 Hughes Hill
    CV35 7AS Shrewley
    Warwickshire
    Amministratore
    The Ashes
    16 Hughes Hill
    CV35 7AS Shrewley
    Warwickshire
    United KingdomBritish109050510001
    TRENFIELD, Alison Jane
    Brackley 90 Main Road
    Baxterley
    CV9 2LE Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    Brackley 90 Main Road
    Baxterley
    CV9 2LE Atherstone
    Warwickshire
    British43478290001
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Amministratore delegato nominato
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005280001

    WOLSELEY RAVEN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 2003
    Consegnato il 11 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,300,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land and buildings known as unifix campus grove lane smethwick warley west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Oakmont Partnership Nominee Company Limited
    Transazioni
    • 11 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 26 set 1997
    Consegnato il 08 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as leverpost limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a land and buildings at grove lane smethwick warlet west midlands t/n WM636859. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 set 1997
    Consegnato il 06 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as leverpost limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0