WORKSPACE 8 LIMITED

WORKSPACE 8 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWORKSPACE 8 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03334863
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WORKSPACE 8 LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova WORKSPACE 8 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Canterbury Court Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WORKSPACE 8 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EXOPORT LIMITED19 mag 199919 mag 1999
    WORKSPACE 4 LIMITED21 gen 199821 gen 1998
    GOLDPINE PROPERTIES LIMITED18 mar 199718 mar 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di WORKSPACE 8 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per WORKSPACE 8 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Chester House Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE a Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE in data 01 nov 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2016

    Stato del capitale al 14 mar 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 feb 2015

    Stato del capitale al 26 feb 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2014

    Stato del capitale al 14 mar 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    4 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Jameson Paul Hopkins come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Harry Platt come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Magenta House 85 Whitechapel Road London E1 1DU* in data 29 lug 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Graham Colin Clement il 02 mar 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Platt il 19 ott 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2010

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di WORKSPACE 8 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARFORA, Carmelina
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Segretario
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    150382170001
    CLEMETT, Graham Colin
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Amministratore
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    United KingdomBritish123744930001
    HOPKINS, Jameson Paul
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Amministratore
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    United KingdomBritish79842180002
    BINNS, Adam
    15 Langhams Way
    Wargrave
    RG10 8AX Reading
    Berkshire
    Segretario
    15 Langhams Way
    Wargrave
    RG10 8AX Reading
    Berkshire
    British113638490001
    MACDONALD, Iain Graham Ross
    172 White Hill
    HP5 1AZ Chesham
    Buckinghamshire
    Segretario
    172 White Hill
    HP5 1AZ Chesham
    Buckinghamshire
    British66669510002
    SAHA, Nirmal Chandra
    Sutherland
    Old Avenue
    KT13 0PQ Weybridge
    Surrey
    Segretario
    Sutherland
    Old Avenue
    KT13 0PQ Weybridge
    Surrey
    British31811850002
    TAYLOR, Robert Mark
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    British43039830001
    WHALLEY, Amanda
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    Segretario
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    British124348320001
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Segretario nominato
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    CARRAGHER, Madeleine
    17 Stadium Street
    Chelsea
    SW10 0PU London
    Amministratore
    17 Stadium Street
    Chelsea
    SW10 0PU London
    British46150230001
    MARPLES, James Patrick
    Churchfield
    All Saints Lane Sutton Courtenay
    OX14 4AG Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Churchfield
    All Saints Lane Sutton Courtenay
    OX14 4AG Abingdon
    Oxfordshire
    British57707320002
    PLATT, Harry
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    United Kingdom
    Amministratore
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish41914500003
    PORTER, Alan Redvers
    The Clock House
    Horsham Road Capel
    RH5 5JJ Dorking
    Surrey
    Amministratore
    The Clock House
    Horsham Road Capel
    RH5 5JJ Dorking
    Surrey
    British17838310001
    TAYLOR, Robert Mark
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    British43039830001
    BRIGHTON DIRECTOR LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Amministratore delegato nominato
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WORKSPACE 8 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Workspace Glebe Limited
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    06 apr 2016
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleEngland And Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WORKSPACE 8 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 13 gen 2003
    Consegnato il 14 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,500,000.00 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/Hold land and buildings at 196-208 (even) kensal road,london W.10 5BN; t/no ngl 303445; fixed charge over all buildings,structures,fixtures and goodwill of business with all plant machinery and other items affixed thereon; the proceeds of all claims made under any insurance.
    Persone aventi diritto
    • Sven Bennie Gray
    Transazioni
    • 14 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of rental assignment
    Creato il 05 giu 1998
    Consegnato il 09 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the companys right title benefit and imnterest (present aor future) in and to all rental monies from any tenant or licencee of property k/a laurence leyland complex irthlingborogh road wellingborough t/no;-NN178476. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Commercial mortgage
    Creato il 05 giu 1998
    Consegnato il 09 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property k/a laurence leyland complex irthlingborough road wellingborogh t/no;-NN178476 all buildings fixtures fixed plant and machinery all estates rights options and privelages thereof, fixed charge the benefit of all guarantees indemnities rent deposits agreements contracts undertakings and warranties relating to the property floating charge undertaking all other property assets and rights of the comnpany not effectively charged by the commercial mortgage an assignment over goodwill of business of the company at the propert and all policies of insurance.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 set 1997
    Consegnato il 03 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Commercial mortgage
    Creato il 30 set 1997
    Consegnato il 03 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the east sidec of brunel drive newark NT211340 and units 1-5 watchmoor park camberley t/no;-SY634897 togerther with buildings fixtures fixed plant machinery benefit of all guarantees indemnities rent deposits agreements contracts undertakings and warranties floating charge all other property assets and rights assignment over goodwill and all policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 25 lug 1997
    Consegnato il 31 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Devonshire works dukes avenue chiswick t/no;-MX5903. 24 highbury grove I slington ad land on the eastern side highbury grove highbury grove islington t/no's;-NGL30173 and NGL635748 and land lying to the north of frail street southwark t/no;-TGL25069 together with all buildings structures and fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon all moveable plant machinery implements utensils stock furniture equipment and other chattels owned hired leased or rented by the company in connection with the property together with goodwill, the benefit of all licences in connection with the business and floating charge all other undertaking and assets of the company whasoever and wheresoever present and future not charged by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West Building Society
    Transazioni
    • 31 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 25 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 25 lug 1997
    Consegnato il 31 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West Building Society
    Transazioni
    • 31 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0