WORKSPACE 8 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WORKSPACE 8 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03334863 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WORKSPACE 8 LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova WORKSPACE 8 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WORKSPACE 8 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EXOPORT LIMITED | 19 mag 1999 | 19 mag 1999 |
| WORKSPACE 4 LIMITED | 21 gen 1998 | 21 gen 1998 |
| GOLDPINE PROPERTIES LIMITED | 18 mar 1997 | 18 mar 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WORKSPACE 8 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per WORKSPACE 8 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Chester House Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE a Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE in data 01 nov 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Jameson Paul Hopkins come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Harry Platt come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Magenta House 85 Whitechapel Road London E1 1DU* in data 29 lug 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Graham Colin Clement il 02 mar 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Platt il 19 ott 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2010 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WORKSPACE 8 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARFORA, Carmelina | Segretario | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | 150382170001 | |||||||
| CLEMETT, Graham Colin | Amministratore | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||
| HOPKINS, Jameson Paul | Amministratore | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | United Kingdom | British | 79842180002 | |||||
| BINNS, Adam | Segretario | 15 Langhams Way Wargrave RG10 8AX Reading Berkshire | British | 113638490001 | ||||||
| MACDONALD, Iain Graham Ross | Segretario | 172 White Hill HP5 1AZ Chesham Buckinghamshire | British | 66669510002 | ||||||
| SAHA, Nirmal Chandra | Segretario | Sutherland Old Avenue KT13 0PQ Weybridge Surrey | British | 31811850002 | ||||||
| TAYLOR, Robert Mark | Segretario | 15 Hollow Way Lane HP6 6DJ Amersham Buckinghamshire | British | 43039830001 | ||||||
| WHALLEY, Amanda | Segretario | 12 Merchant Court 61 Wapping Wall Wapping E1W 3SD London | British | 124348320001 | ||||||
| BRIGHTON SECRETARY LIMITED | Segretario nominato | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex | 900004700001 | |||||||
| CARRAGHER, Madeleine | Amministratore | 17 Stadium Street Chelsea SW10 0PU London | British | 46150230001 | ||||||
| MARPLES, James Patrick | Amministratore | Churchfield All Saints Lane Sutton Courtenay OX14 4AG Abingdon Oxfordshire | British | 57707320002 | ||||||
| PLATT, Harry | Amministratore | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Chester House United Kingdom | United Kingdom | British | 41914500003 | |||||
| PORTER, Alan Redvers | Amministratore | The Clock House Horsham Road Capel RH5 5JJ Dorking Surrey | British | 17838310001 | ||||||
| TAYLOR, Robert Mark | Amministratore | 15 Hollow Way Lane HP6 6DJ Amersham Buckinghamshire | British | 43039830001 | ||||||
| BRIGHTON DIRECTOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex | 900004690001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WORKSPACE 8 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace Glebe Limited | 06 apr 2016 | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
WORKSPACE 8 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 13 gen 2003 Consegnato il 14 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,500,000.00 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/Hold land and buildings at 196-208 (even) kensal road,london W.10 5BN; t/no ngl 303445; fixed charge over all buildings,structures,fixtures and goodwill of business with all plant machinery and other items affixed thereon; the proceeds of all claims made under any insurance. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of rental assignment | Creato il 05 giu 1998 Consegnato il 09 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the companys right title benefit and imnterest (present aor future) in and to all rental monies from any tenant or licencee of property k/a laurence leyland complex irthlingborogh road wellingborough t/no;-NN178476. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Commercial mortgage | Creato il 05 giu 1998 Consegnato il 09 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Legal mortgage over property k/a laurence leyland complex irthlingborough road wellingborogh t/no;-NN178476 all buildings fixtures fixed plant and machinery all estates rights options and privelages thereof, fixed charge the benefit of all guarantees indemnities rent deposits agreements contracts undertakings and warranties relating to the property floating charge undertaking all other property assets and rights of the comnpany not effectively charged by the commercial mortgage an assignment over goodwill of business of the company at the propert and all policies of insurance. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 set 1997 Consegnato il 03 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Commercial mortgage | Creato il 30 set 1997 Consegnato il 03 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the east sidec of brunel drive newark NT211340 and units 1-5 watchmoor park camberley t/no;-SY634897 togerther with buildings fixtures fixed plant machinery benefit of all guarantees indemnities rent deposits agreements contracts undertakings and warranties floating charge all other property assets and rights assignment over goodwill and all policies of insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage deed | Creato il 25 lug 1997 Consegnato il 31 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Devonshire works dukes avenue chiswick t/no;-MX5903. 24 highbury grove I slington ad land on the eastern side highbury grove highbury grove islington t/no's;-NGL30173 and NGL635748 and land lying to the north of frail street southwark t/no;-TGL25069 together with all buildings structures and fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon all moveable plant machinery implements utensils stock furniture equipment and other chattels owned hired leased or rented by the company in connection with the property together with goodwill, the benefit of all licences in connection with the business and floating charge all other undertaking and assets of the company whasoever and wheresoever present and future not charged by way of fixed charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 25 lug 1997 Consegnato il 31 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0