WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED

WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03337345
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    • Altre installazioni in costruzioni (43290) / Costruzioni

    Dove si trova WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Paul Scott come amministratore in data 22 gen 2015

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr John William Young Strachan Samuel come amministratore in data 22 gen 2015

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2015

    Stato del capitale al 08 gen 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2014

    Stato del capitale al 06 gen 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2008

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Segretario
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    HILL, David Robert
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    Segretario
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    British18429260002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    DAWES, John Brian
    Holly Lodge
    Arkleby
    CA7 2BT Wigton
    Cumbria
    Amministratore
    Holly Lodge
    Arkleby
    CA7 2BT Wigton
    Cumbria
    EnglandBritish10253750001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Amministratore
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    HILL, David Robert
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    Amministratore
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    British18429260002
    LITTLEHALES, Richard
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    British57288230002
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    PEARSON, Valerie
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    Amministratore
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    British82999480006
    SCOTT, Paul
    The Burroughs
    Papcastle
    CA13 0JN Cockermouth
    Cumbria
    Amministratore
    The Burroughs
    Papcastle
    CA13 0JN Cockermouth
    Cumbria
    EnglandBritish63708460003
    UNDERWOOD, Philip John
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British59420330009
    WAREING, Anthony James
    4 Craig Road
    CA14 3JX Workington
    Cumbria
    Amministratore
    4 Craig Road
    CA14 3JX Workington
    Cumbria
    United KingdomBritish17422620001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 gen 2005
    Consegnato il 20 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 apr 1999
    Consegnato il 20 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 09 mag 1997
    Consegnato il 14 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0