HAZEL MOUNT COMPANY LIMITED

HAZEL MOUNT COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAZEL MOUNT COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03337618
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAZEL MOUNT COMPANY LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova HAZEL MOUNT COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    FRP ADVISORY LLP
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAZEL MOUNT COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per HAZEL MOUNT COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Ribblesdale Place Preston Lancashire PR1 8BZ a Derby House 12 Winckley Square Preston PR1 3JJ in data 02 ago 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 lug 2018

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Penelope Jane Messel come amministratore in data 23 mag 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jocelyn Anne D'oyly Davison come amministratore in data 23 mag 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Andrew Jonathan Makin come amministratore in data 22 mag 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Penelope Jane Messel il 20 dic 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Jocelyn Anne D'oyly Davison il 24 ott 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 17 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mar 2016

    Stato del capitale al 21 mar 2016

    • Capitale: GBP 484,300
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    6 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 12 set 2015 al 31 mar 2015

    3 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di HAZEL MOUNT COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JACKSON, Rowland Frederick Hart
    8 & 10 New Market Street
    LA12 7LW Ulverston
    Cumbria
    Segretario
    8 & 10 New Market Street
    LA12 7LW Ulverston
    Cumbria
    British51905560001
    MAKIN, Andrew Jonathan
    Ribblesdale Place
    PR1 8BZ Preston
    5
    England
    Amministratore
    Ribblesdale Place
    PR1 8BZ Preston
    5
    England
    EnglandBritish6535110004
    ALLEN, Andrew John
    Binden Road
    W12 9RJ London
    16
    Segretario
    Binden Road
    W12 9RJ London
    16
    British15749190001
    BARRATT, Jacqueline Diana
    Hazel Mount
    Thwaites
    LA18 5HY Millom
    Cumbria
    Amministratore
    Hazel Mount
    Thwaites
    LA18 5HY Millom
    Cumbria
    EnglandBritish51905550001
    DAVISON, Jocelyn Anne D'Oyly
    5 Ribblesdale Place Preston
    Lancashire
    PR1 8BZ
    Amministratore
    5 Ribblesdale Place Preston
    Lancashire
    PR1 8BZ
    New ZealandNew Zealander160253580002
    MAKIN, Peter
    Links Grange
    Greenways
    FY8 3LY Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    Links Grange
    Greenways
    FY8 3LY Lytham St Annes
    Lancashire
    British14196200001
    MESSEL, Penelope Jane
    5 Ribblesdale Place Preston
    Lancashire
    PR1 8BZ
    Amministratore
    5 Ribblesdale Place Preston
    Lancashire
    PR1 8BZ
    EnglandBritish160267260002

    Chi sono le persone con controllo significativo di HAZEL MOUNT COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Jocelyn Anne D'Oyly Davison
    12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Derby House
    06 apr 2016
    12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Derby House
    No
    Nazionalità: New Zealander
    Paese di residenza: New Zealand
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Penelope Jane Messel
    12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Derby House
    06 apr 2016
    12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Derby House
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    HAZEL MOUNT COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental agreement
    Creato il 27 feb 2004
    Consegnato il 02 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    4 alton road parkstone poole dorset and the contracts with the companies firms and persons referred to in a partnership agreement dated 18 june 2003. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gornal Ground Company Limited, Lollesworth Property Limited, Longbarrow Limited,Lowry Peaks Company Limited, Oakendell Developments Limited, Templeflight Limited, Starguard Developments Limited
    Transazioni
    • 02 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge and assignment over a performance bond
    Creato il 16 set 2003
    Consegnato il 23 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest to in and arising out or in respect of the agreements and all rights titles benefits monies receivable and interests of the chargor (as defined whatsoever under arising from them or evidenced by them together with the chargors estate or interest in any property the subject of the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Partnership agreement
    Creato il 18 giu 2003
    Consegnato il 20 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums becoming due from the company to the other parties to the partnership agreement (being the persons entitled to the charge) in respect of its obligations under the partnership agreement to such other parties
    Brevi particolari
    3 wyndham road and 2 alton road parkstone pool dorset t/nos: DT190922 and DT300802.
    Persone aventi diritto
    • Gornal Ground Company Limited and Others
    Transazioni
    • 20 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 24TH may 2001
    Creato il 14 mag 2001
    Consegnato il 07 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19/27 hopetoun crescent and 8/12 mcdonald road edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Partnership agreement
    Creato il 09 mar 2000
    Consegnato il 17 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The performance by the company to the chargee of its obligations under the partnership agreement
    Brevi particolari
    19-29 (odd numbers) hoptoun crescent and 8-12 mcdonald road (even numbers) edinburgh as referred to in the proect management agreement the interest of the company in contracts the benefit of all warranties and indemnities.
    Persone aventi diritto
    • Archibald Industries Limited, Bradburian Developments Limited, Cat Street Developments Limited, Chevithorne Barton Limited, Deep Valley Properties Limited, Endicott Estates Limited, Gape Estates Limited, Gornal Ground Company Limited, Kiwi Properties Limited,
    • Lollesworth Property Limited, Lowry Peaks Company Limited and Tayvin 91 Limited
    Transazioni
    • 17 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 15TH march 2001
    Creato il 08 mar 2000
    Consegnato il 03 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in terms of clauses 4,5,6 and 7 of the sale agreement between the company and the chargee dated 23RD march and 1ST june 2000
    Brevi particolari
    Ground floor and basement floor of that tenement erected or to be erevcted at 27 hopetoun crescent edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scottish & Newcastle PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 23 december 1998 and
    Creato il 17 dic 1998
    Consegnato il 07 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee or their foresaids in any manner of way by (a) the firm of the st john's road partnership of whomsoever constituted comprising kiwi properties limited, bradburian developments limited, hazel mount company limited, gornal ground company limited and lowry peaks company limited the present partners thereof or any partners for the time being or successors with or to them or either/any one of them or the survivor as partners aforesaid either solely or jointly with any person(s) or corporation and whether as principal or surety and/or (b) to the extent of the proceeds of realisation of the subjects of any security referring to the personal bond any of them as individuals whether solely or jointly with any person(s) or corporation and whether as principal or surety
    Brevi particolari
    All and whole that piece of ground extending to 515 decimal or one thousandth parts of an acre or thereby lying on the north side of st john's road corstorphine edinburgh together with the dwellinghouse erected thereon and formerly k/a "dorlin" (for further details of property please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Partnership agreement
    Creato il 09 gen 1998
    Consegnato il 16 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The performance of the company of its obligations under the partnership agreement dated 9TH january 1998
    Brevi particolari
    The interest in common of the company in the property at and k/a 24ST.john's road edinburgh and the interest of the company in contracts entered into by the partnership subject to the deed inclusive opf any insurance covering such property and the benefit of all warranties and indemnities to the partners in such partnership.
    Persone aventi diritto
    • Gornal Ground Company Limited
    • Bradburian Developments Limited
    • Kiwi Properties Limited
    • Lowry Peaks Company Limited
    Transazioni
    • 16 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    HAZEL MOUNT COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 lug 2018Inizio della liquidazione
    16 ott 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Lila Thomas
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lancashire
    Praticante
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lancashire
    David Robert Acland
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Praticante
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0