RIVERSIDE CROYDON LIMITED

RIVERSIDE CROYDON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRIVERSIDE CROYDON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03340555
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    • Centri di fitness (93130) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE England

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da , Active House 21 North Fourth Street, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 1HL in data 09 ott 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 19 set 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 29 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr Paul Antony Woolf come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Norman Field come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Matthew Graham Merrick come amministratore

    4 pagineAP01
    Note
    DataNota
    27 set 2011The form is a duplicate of AP01 registered on 12/09/2011

    Nomina di James Archibald come segretario

    4 pagineAP03
    Note
    DataNota
    27 set 2011The form is a duplicate of AP03 registered on 12/09/2011

    Nomina di James Archibald come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Matthew Graham Merrick come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARCHIBALD, James
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Segretario
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    British162966660001
    BUCKNALL, Matthew William
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Amministratore
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritish162066820001
    MERRICK, Matthew Graham
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Amministratore
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritish162110530001
    WOOLF, Paul Antony
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Amministratore
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritish160679880001
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    Segretario
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    British46410260001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Segretario
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    DREGENT, Patricia Ann Taylor
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    Segretario
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    British6369240002
    PENRICE, Victoria Margaret
    Trebartha
    51a Frances Road
    SL4 3AQ Windsor
    Berkshire
    Segretario
    Trebartha
    51a Frances Road
    SL4 3AQ Windsor
    Berkshire
    British90459300001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Segretario
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WHEELER, Jonathan
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    Segretario
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    British19812400001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Segretario
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    British123616460002
    ANDERSON, Ruth
    46 Upper Grotto Road
    Strawberry Hill
    TW1 4NF Twickenham
    Amministratore
    46 Upper Grotto Road
    Strawberry Hill
    TW1 4NF Twickenham
    British66859670001
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    Amministratore
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    EnglandBritish46410260001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish58961410002
    BEADLE, Mark Ronald Sydney
    14 Fen Meadow
    TN15 9HT Ightham
    Kent
    Amministratore
    14 Fen Meadow
    TN15 9HT Ightham
    Kent
    British80515670001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Amministratore
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritish96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish146698270001
    COLES, Charles Graham
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritish12337010002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    Amministratore
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritish3716600001
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish104269910002
    FIELD, Norman Mark
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    Amministratore
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomSouth African161860310001
    FOSTER, Michael Raymond
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    Amministratore
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    EnglandBritish53280440001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritish69204500003
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Amministratore
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    British100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HENCHOZ, Patrick
    Huntington Court
    Huntington Lane
    HR4 7RA Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    Huntington Court
    Huntington Lane
    HR4 7RA Hereford
    Herefordshire
    United KingdomSwiss93431850001
    JOHNSON, Mark Christopher
    Little Stream
    Sunning Hill Road
    SL5 9JZ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Little Stream
    Sunning Hill Road
    SL5 9JZ Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish48443030001
    KELLY, Maurice William
    Spinney Cottage Wing Road
    Mentmore
    LU7 0QG Leighton Buzzard
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Spinney Cottage Wing Road
    Mentmore
    LU7 0QG Leighton Buzzard
    Buckinghamshire
    British89366130001
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish135618280002
    MCCOLLUM, Kevin Boyd
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish121972580001
    MCGUIGAN, Marc Edward
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    Amministratore
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    EnglandBritish93677590002
    MCRORY, Penelope Ann
    13 Queen Street
    KT16 8BS Chertsey
    Surrey
    Amministratore
    13 Queen Street
    KT16 8BS Chertsey
    Surrey
    British52251860001
    MICHAELS, Terry
    The Vines Hardwick Close
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    The Vines Hardwick Close
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    New Zealand72228080001

    RIVERSIDE CROYDON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 18 giu 2009
    Consegnato il 26 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group debenture
    Creato il 08 feb 2006
    Consegnato il 18 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transazioni
    • 18 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2004
    Consegnato il 07 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Transazioni
    • 07 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2004
    Consegnato il 03 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RIVERSIDE CROYDON LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 set 2013Inizio della liquidazione
    20 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Praticante
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0