RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED

RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03341350
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    • Attività combinate di supporto alle strutture (81100) / Attività amministrative e di supporto
    • Altri servizi di pulizia (81299) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARILLION PALL MALL LIMITED31 mag 200631 mag 2006
    MOWLEM PALL MALL LIMITED10 feb 200410 feb 2004
    PALL MALL SUPPORT SERVICES LIMITED03 apr 199703 apr 1997
    TRUSHELFCO (NO.2227) LIMITED27 mar 199727 mar 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    22 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 mar 2020

    24 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    9 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 mar 2019

    26 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 mar 2018

    24 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Innovation House Bullerthorpe Lane Colton Leeds West Yorkshire LS15 9JL a Kpmg 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH in data 29 mag 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 mar 2017

    13 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 mar 2017

    13 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 16 mar 2016

    16 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 17 set 2015

    14 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 17 mar 2015

    26 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    25 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    29 pagine2.17B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    29 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard William Taylor Gray il 05 set 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 27 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2014

    Stato del capitale al 08 apr 2014

    • Capitale: GBP 1,000,003
    SH01

    Nomina di Mr John King come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Seaton come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    33 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DANIEL, Mark Richard
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Segretario
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    178838610001
    FORAN, Raymond Christopher
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Amministratore
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    IrelandIrishCompany Director149366250001
    GRAY, Richard William Taylor
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Amministratore
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    ScotlandBritishDirector111454800002
    KING, John
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Amministratore
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    IrelandIrishCompany Director184461620001
    BARKER, Nigel
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Segretario
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    British153013180001
    FOSTER, Robert
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    Segretario
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    BritishDirector38619010002
    HARKIN, Niall
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Segretario
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    BritishFinance Director125430560001
    LAWRENCE, David
    45 Griffith Avenue
    Drumcondra
    Dublin 9
    Republic Of Ireland
    Segretario
    45 Griffith Avenue
    Drumcondra
    Dublin 9
    Republic Of Ireland
    British136692630001
    MACNAMARA, James Justin
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    Segretario
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    BritishFinance Director204243460001
    CARILLION SECRETARIAT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    33743910002
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Segretario nominato
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    BEAN, Paul Francis
    10 Ormiston Farm Steadings
    Kirknewton
    EH27 0DQ Edinburgh
    West Lothian
    Amministratore
    10 Ormiston Farm Steadings
    Kirknewton
    EH27 0DQ Edinburgh
    West Lothian
    United KingdomBritishCompany Director125759470001
    BOYLE, George Mathieson
    Strathern House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Strathern House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector102046460001
    BRANNIGAN, Terence Hugh
    West Cliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    17
    North Yorkshire
    Amministratore
    West Cliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    17
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director125430930001
    DAY, Stephen John
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    Amministratore
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    EnglandBritishDirector59028300002
    FORAN, Raymond Christopher
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    IrelandIrishDirector149366250001
    FOSTER, Robert
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    Amministratore
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    EnglandBritishDirector38619010002
    HARKIN, Niall
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Amministratore
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Northern IrelandBritishFinance Director125430560001
    IVEY, John Charles
    Tregenna 32 The Glen
    Farnborough Park
    BR6 8LR Orpington
    Kent
    Amministratore
    Tregenna 32 The Glen
    Farnborough Park
    BR6 8LR Orpington
    Kent
    BritishDirector8286080001
    MACNAMARA, James Justin
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    Amministratore
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    EnglandBritishDirector204243460001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector96596920001
    ROWE, Drusilla Charlotte Jane
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    Amministratore delegato nominato
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    British900010990001
    SEATON, David John
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector66233040004
    SHEPLEY, Philip Ernest
    15 Whitmore Road
    Beckenham
    BR3 3NU Kent
    Amministratore
    15 Whitmore Road
    Beckenham
    BR3 3NU Kent
    United KingdomBritishCustomer Services Director122662180001
    VAUGHAN, Andrew David
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector110679680001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    3 Shires Orchard
    Croxton Kerral
    NG32 1RD Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    3 Shires Orchard
    Croxton Kerral
    NG32 1RD Grantham
    Lincolnshire
    BritishManaging Director123410850001
    WOODS, David
    12 Rainsborough Rise
    Thorpe St Andrew
    NR7 0TR Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    12 Rainsborough Rise
    Thorpe St Andrew
    NR7 0TR Norwich
    Norfolk
    BritishDirector11156100002
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    26 Springfield Road
    Linslade
    LU7 7QS Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore delegato nominato
    26 Springfield Road
    Linslade
    LU7 7QS Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British900014530001
    CARILLION MANAGEMENT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    36778210004

    RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 23 dic 2010
    Consegnato il 08 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A first fixed equitable charge over the deposit balance being the balance from time to time standing to the credit of the deposit account being a separate interest bearing account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Pollen Estate Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 08 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 set 2007
    Consegnato il 19 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the comapny to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 16 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the parent company (as defined) or the company to the chargee (the "security trustee") as trustee for itself and the noteholders under or in connection with the notes (as defined) or the mortgage debenture together with the expenses (as defined)
    Brevi particolari
    141/157 acre lane brixton london; rooms 36-37 first floor lingley house commissioners road streed kent; 1 st michaels court church street newport gwent .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wren Investments Limited
    Transazioni
    • 16 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 14 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever under the financing documents or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 nov 1997
    Consegnato il 15 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from any company to the chargee and to any beneficiary (as defined) under or in connection with the notes (as defined) or this deed
    Brevi particolari
    141/157 acre lane brixton london; rooms 36/37 first floor lingley house, commissioners road strood kent; unit 3 evtol trading estate portland street, newport gwent .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wren Investments Limited (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 15 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 nov 1997
    Consegnato il 12 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 set 2014Inizio dell'amministrazione
    24 mar 2016Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Praticante
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Stuart Irwin
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Praticante
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    2
    DataTipo
    24 mar 2016Inizio della liquidazione
    04 nov 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Leonard
    1 Lanyon Place
    BT1 3LP Belfast
    County Antrim
    Praticante
    1 Lanyon Place
    BT1 3LP Belfast
    County Antrim
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Liquidatore proposto
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Stuart Irwin
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Liquidatore proposto
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Stuart Irwin
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Praticante
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Praticante
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0