STEPHIGH LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTEPHIGH LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03346861
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STEPHIGH LTD?

    • (8514) /

    Dove si trova STEPHIGH LTD?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di STEPHIGH LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per STEPHIGH LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 mag 2010

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Bridge House, Outwood Lane Horsforth Leeds LS18 4UP in data 16 giu 2010

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Simon Reiter come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Ellerby come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    10 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Fraser David Gregory il 13 mag 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 08 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2010

    Stato del capitale al 28 apr 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Tetley Beazley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Philip Reiter il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mahboob Ali Merchant il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Fraser David Gregory il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Ellerby il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 07/01/2009
    RES13

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di STEPHIGH LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Segretario
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Amministratore
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270003
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Amministratore
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Segretario
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Segretario nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    MASONS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    30 Aylesbury Street
    EC1R 0ER London
    Segretario
    30 Aylesbury Street
    EC1R 0ER London
    32643220001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Segretario
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001
    CLINTON, David
    Breen Cottage
    63 Station Road
    AB31 5UD Banchory
    Kincardineshire
    Amministratore
    Breen Cottage
    63 Station Road
    AB31 5UD Banchory
    Kincardineshire
    United KingdomBritish30279690002
    DALY, Geoffrey William Stuart
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    Amministratore
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    United KingdomBritish19464860003
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DHANDSA, Narinder, Dr
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    Amministratore
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    EnglandBritish115844000001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    HOUGHTON, George
    Pine Dene
    Dissington Lane
    NE15 0AE Ponteland
    Northumerland
    Amministratore
    Pine Dene
    Dissington Lane
    NE15 0AE Ponteland
    Northumerland
    United KingdomBritish29555780001
    HOUGHTON, George
    Tyne View House Askew Road West
    NE8 2JX Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Tyne View House Askew Road West
    NE8 2JX Gateshead
    Tyne & Wear
    British52580210003
    HOUGHTON, Jennifer Pamela
    Primrose Lodge
    Dissington Lane
    NE15 0AB Ponteland
    Northumberland
    Amministratore
    Primrose Lodge
    Dissington Lane
    NE15 0AB Ponteland
    Northumberland
    EnglandBritish48281920002
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    LUKE, George, Mr.
    4 Kirkside
    New Herrington
    DH4 4NX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    4 Kirkside
    New Herrington
    DH4 4NX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    EnglandBritish45765040001
    REITER, Simon Philip
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    Amministratore
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    United KingdomBritish135845570001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Amministratore
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001
    ANS NOMINEES LIMITED
    1 Battersea Square
    SW11 3PZ London
    Amministratore
    1 Battersea Square
    SW11 3PZ London
    68699250001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Amministratore delegato nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    STEPHIGH LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 gen 2004
    Consegnato il 14 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2001
    Consegnato il 11 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) whether for its own account or as trustee for the secured parties (as defined) or any of the other secured parties including any liability in respect of any further advances made under the facility (as defined) or the mezzanine loan facility (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 20 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a eye hospital wilton avenue southamptom t/no HP422098 goodwill and proceeds of insurance thereon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 10 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    1). f/h land and buildings k/a summerlands lodge nursing home 123 canterbury road westgage on sea keny t/no;-0K571115 2). f/h land and buildings k/a warrens hall nursing mhome 218 oakham road tividale warley west midlands t/no;-WM459415 3). f/h land k/a the site of the former eye hospital wilton avenue southampton t/no;-HP422098 any other property belonging or charged to the company during the contuance of this security all stocks shares and related rights all book and other debts goodwill and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Associated Nursing Services PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 1997
    Consegnato il 20 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 218 oakham road tividale warley west midlands t/no;-WM459415 goodwill andthe proceeds of insurance thereon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 1997
    Consegnato il 20 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a piper house 123 canterbury road westgate -on-sea t/no;-K571115 goodwill and the proceeds of insurance thereof. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 mag 1997
    Consegnato il 14 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    STEPHIGH LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 gen 2011Data di scioglimento
    26 mag 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0