IMCO RECONOMY 5 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | IMCO RECONOMY 5 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03347372 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
- Raccolta di rifiuti non pericolosi (38110) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica
Dove si trova IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Shropshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SKIPS@HOME LIMITED | 18 apr 2007 | 18 apr 2007 |
| WELLS FARGO SKIPS LIMITED | 08 apr 1997 | 08 apr 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Coldbath Square London EC1R 5HL a Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD in data 26 lug 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Sullivan come segretario in data 21 lug 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Llewelyn Milnes-James come amministratore in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Charles Nicholas Pollard come amministratore in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alistair Myrie Holl come amministratore in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Caroline Elizabeth Allen come segretario in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr John Terence Sullivan come amministratore in data 21 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Cox come amministratore in data 21 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 033473720005 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Secondo deposito di TM02 precedentemente inviato alla Camera di Commercio | 5 pagine | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Caroline Elizabeth Allen come segretario in data 11 apr 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sophie Catherine Jane Reed come segretario in data 01 apr 2016 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Anton Gerstrom come amministratore in data 01 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Charles Nicholas Pollard come amministratore in data 01 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULLIVAN, John | Segretario | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | 210820120001 | |||||||
| COX, Paul Anthony | Amministratore | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | 153797870001 | |||||
| SULLIVAN, John Terence | Amministratore | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | 180046340001 | |||||
| ALLEN, Caroline Elizabeth | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 208085190001 | |||||||
| DIXON, Sally Veronica | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | British | 105363350001 | ||||||
| JESKE, Riga | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 189290690001 | |||||||
| KAHVECI, Suheda | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 176235280001 | |||||||
| PHILLIPS, Elizabeth Clare | Segretario | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 56302980001 | ||||||
| REED, Sophie Catherine Jane | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 198174110001 | |||||||
| SCOTT, Stephen John | Segretario nominato | 52 Mucklow Hill Halesowen B62 8BL Birmingham | British | 900002270001 | ||||||
| WELLS, Jennifer Ann | Segretario | 20a Collett Way Priorslee TF2 9SL Telford Salop | British | 63479470001 | ||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | 32524900007 | |||||||
| DIXON, Sally Veronica | Amministratore | 22 Ardleigh Road N1 4HP London | England | British | 105363350001 | |||||
| GERSTROM, Peter Anton | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | 138719750001 | |||||
| HARRISON, Julian John | Amministratore | 24 Havelock Road SY3 7NE Shrewsbury Salop | England | British | 123927990001 | |||||
| HOLL, Alistair Myrie | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | Wales | British | 138014840001 | |||||
| JOHNSON, Peter Stuart | Amministratore | The Old Post Office Church Road West Peckham ME18 5JL Maidstone Kent | England | British | 11159620001 | |||||
| MILNES-JAMES, Richard Llewelyn | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 140753960001 | |||||
| PHILLIPS, John | Amministratore | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 343070001 | ||||||
| POLLARD, Charles Nicholas | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | 192011710001 | |||||
| RIDDLE, David Ellison | Amministratore | 3 Lovelace Road KT6 6NS Surbiton Surrey | England | British | 556710002 | |||||
| SCOTT, Jacqueline | Amministratore delegato nominato | 52 Mucklow Hill Halesowen B62 8BL Birmingham | British | 900002260001 | ||||||
| STEGGLES, Jonathan David | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 45141530001 | |||||
| WARD, Malcolm John | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 57775660003 | |||||
| WELLS, Peter | Amministratore | 20a Collett Way Priorslee TF2 9SL Telford Salop | British | 45937400001 | ||||||
| WILLACY, Richard Johannes Ormerod | Amministratore | Wraymead 158 Croydon Road RH2 0NG Reigate Surrey | United Kingdom | British | 92108930002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Hire Service Limited | 06 apr 2016 | Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
IMCO RECONOMY 5 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 20 ago 2015 Consegnato il 27 ago 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A supplemental common debenture | Creato il 29 nov 2011 Consegnato il 08 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession | Creato il 18 mag 2007 Consegnato il 25 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 apr 2005 Consegnato il 11 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| First fixed and floating charge | Creato il 26 mag 1999 Consegnato il 04 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari A first fixed charge on all book and other debts as are not sold or bought by alex lawrie receivable financing limited under an agreement dated 2ND june 1999 and a floating charge all proceeds of book and other debts with the payment of any sum due or owing to alex lawrie receivables financing limited under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument to which both the company and alex lawrie receivables financing limited are a party. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0