TURNFAIR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTURNFAIR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03348209
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TURNFAIR LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova TURNFAIR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    13 Police Street
    M2 7LQ Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TURNFAIR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TURNFAIR LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TURNFAIR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mag 2015

    Stato del capitale al 02 mag 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mag 2014

    Stato del capitale al 07 mag 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 13 Police Street Manchester M2 7LQ England* in data 07 mag 2014

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 6 Brookfield House Higher Precinct Holcombe Brook Bury Lancashire BL0 9RN* in data 07 mag 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2011

    7 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2009

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2007

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    annual-return04 giu 2007

    legacy

    363(288)

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2006

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TURNFAIR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPEAKMAN, David William Henry
    9 Maldon Road
    Standish
    WN6 0EX Wigan
    Lancashire
    Segretario
    9 Maldon Road
    Standish
    WN6 0EX Wigan
    Lancashire
    British34006940001
    HARRISON, Paul Darren
    Hall Street
    Walshaw
    BL8 3BE Bury
    21-23
    Lancashire
    Amministratore
    Hall Street
    Walshaw
    BL8 3BE Bury
    21-23
    Lancashire
    EnglandBritish96445910001
    HARRISON, Mark Andrew
    2 Brookfield House
    Holcombe Brook
    BL0 9RN Bury
    Lancashire
    Segretario
    2 Brookfield House
    Holcombe Brook
    BL0 9RN Bury
    Lancashire
    British62155720002
    HARRISON, Paul Darren
    Hall Street
    Walshaw
    BL8 3BE Bury
    21-23
    Lancashire
    Segretario
    Hall Street
    Walshaw
    BL8 3BE Bury
    21-23
    Lancashire
    British96445910001
    SPEAKMAN, David William Henry
    9 Maldon Road
    Standish
    WN6 0EX Wigan
    Lancashire
    Segretario
    9 Maldon Road
    Standish
    WN6 0EX Wigan
    Lancashire
    British34006940001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    HARRISON, Mark Andrew
    2 Brookfield House
    Holcombe Brook
    BL0 9RN Bury
    Lancashire
    Amministratore
    2 Brookfield House
    Holcombe Brook
    BL0 9RN Bury
    Lancashire
    British62155720002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    TURNFAIR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 26 lug 2000
    In corso
    Importo garantito
    £14,236.00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    471 and 473 warrington rd,ince-in-makerfield,wigan; GM724982. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 26 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 26 lug 2000
    In corso
    Importo garantito
    £39,631.00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    55 and 55A darlington street east,wigan; GM470156. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 26 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 26 lug 2000
    In corso
    Importo garantito
    £13,328.00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    469 warrington rd,ince-in-makerfield,wigan; GM698560. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 26 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 26 lug 2000
    In corso
    Importo garantito
    £10,350.00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    467 warrington rd,ince-in-makerfield,wigan; GM262287. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 26 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 31 ago 1999
    Consegnato il 01 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £12,250.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H property numbered 17 philips street leigh greater manchester and all the company's uncalled capital and other f/h and l/h property by way of floating security all undertaking goodwill assets and rights and the goodwill and connection of any business.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 01 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 06 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £37,250 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    55 & 55A darlington street east, wigan-GM470156..all its uncalled capital and all other f/h & l/h property..floating security all the undertaking and goodwill of the company.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 06 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 lug 1999
    Consegnato il 27 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £12,250.00 (with interest) due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    469 warrington rd,ince-in-makerfield,wigan; t/no gm 698560; the goodwill of business. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 27 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 1999
    Consegnato il 18 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £13,085.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    471 and 473 warrington road ince-in-makerfield wogan (GM724982). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 18 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 1999
    Consegnato il 18 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £9,250.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    467 warrington road ince-in- makerfield wigan (GM262287). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 18 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 feb 1999
    Consegnato il 18 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £9,953 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    7 warrington road leigh lancs t/no: GM382032 whatsoever and wheresoever both present and future and the goodwill of the business. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 18 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 set 1998
    Consegnato il 22 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £24,872 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    26 swinley road wigan lancs t/no: GM760926 floating charge on whatsoever and wheresoever present and future and the goodwill of the business. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 22 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    21, 23, 25 king street wigan lancashire.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a 3 shirebrook drive redcliffe near bury greater manchester t/no;-GM590754.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 13 hallworth road crumpsall manchester t/no;-GM466787.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a 35 coalshaw green road oldham greater manchester t/no;-LA197972.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 205 thornton road rucholme manchester t/no;-GM355478.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a 17 cheapside middleton manchester t/no;-GM459276.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 15 spencer avemue whallet range manchester (GM181634.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 246 market street whitworth rossendale lancashire t/no;-LA445327.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 1997
    Consegnato il 27 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H properties k/a 27 upper dicconson street wigan 29 upper dicconson street wigan and 31 upper dicconson street wigan t/nos. GM220147, GM219437 and GM253259.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mag 1997
    Consegnato il 29 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 29 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 mag 1997
    Consegnato il 29 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    7 cameron street burnley, 28 laithe street burnley, 23 rosegrove lane burnley. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 29 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0