COACH HOLIDAY GROUP LIMITED

COACH HOLIDAY GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOACH HOLIDAY GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03353865
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WALLACE ARNOLD GROUP LIMITED09 lug 199709 lug 1997
    INHOCO 640 LIMITED16 apr 199716 apr 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    12 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2021

    10 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di a G Secretarial Limited come segretario in data 22 mar 2020

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ United Kingdom a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR in data 22 lug 2020

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 22 mag 2020

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività

    10 pagineLIQ02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Gary Speakman come amministratore in data 31 dic 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Paul David Smith come amministratore in data 01 ott 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Vincent Flower come amministratore in data 01 ott 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Graham John Rogers il 12 set 2018

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Shearings Leisure Group Limited come persona con controllo significativo il 05 giu 2018

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Memorandum e Statuto

    36 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dettagli del direttore cambiati per Graham John Rogers il 13 nov 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary Speakman il 13 nov 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Vincent Flower il 13 nov 2017

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Shearings Leisure Group Limited come persona con controllo significativo il 13 nov 2017

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Shearings Group Limited come persona con controllo significativo il 13 nov 2017

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Victoria Mill Miry Lane Wigan WN3 4AG a Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ in data 13 nov 2017

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CALVERT, Richard James
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritishCeo163434180002
    ROGERS, Graham John
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69494710002
    SMITH, Paul David
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant228581750001
    HINSLIFF, Robert
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    British51000070001
    MEDDES, Kenneth Sydney
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    Segretario
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    BritishDirector11486330002
    THOMAS, Joan Valerie
    3 Broom Road
    LS24 9LH Tadcaster
    North Yorkshire
    Segretario
    3 Broom Road
    LS24 9LH Tadcaster
    North Yorkshire
    British51418740001
    TURNER, Jayne Marie
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    Segretario
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    BritishAccountant117561640001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Segretario
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    90084920001
    BARBER, Stephen Donald
    5 Springbank Close
    Farsley Pudsey
    LS28 5TP Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Springbank Close
    Farsley Pudsey
    LS28 5TP Leeds
    West Yorkshire
    BritishOperations Dir11617040001
    BARR, Robert Adam
    Crow House Farm
    Burton Leonard
    HG3 3SX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Crow House Farm
    Burton Leonard
    HG3 3SX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDeputy Chairman28813320001
    FLOWER, Vincent
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director91542970002
    GILMORE, Nicholas John
    76 Ilsham Road
    TQ1 2HY Torquay
    Devon
    Amministratore
    76 Ilsham Road
    TQ1 2HY Torquay
    Devon
    BritishDirector53768550001
    MAXWELL, William
    Snelsins House
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire
    Amministratore
    Snelsins House
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector108831380001
    MEDDES, Kenneth Sydney
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    Amministratore
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    United KingdomBritishManaging Director11486330002
    NEWBOLD, David Robert
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director30276880001
    NORMAN, Bernard Robert
    Brackley House
    Marholm Road Ufford
    PE9 3BL Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    Brackley House
    Marholm Road Ufford
    PE9 3BL Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director65467300001
    O'CALLAGHAN, Joseph
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector110216340001
    SLATCHER, David John
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    BritishCompany Director104434750001
    SPEAKMAN, Gary
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director56066860001
    WORMWELL, Denis
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer124681340001
    WORSNUP, Peter Jonathan
    12 Grantley Place
    Bradley
    HD2 1LZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Grantley Place
    Bradley
    HD2 1LZ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant95865490001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di COACH HOLIDAY GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5272464
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09009187
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    COACH HOLIDAY GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and set-off agreement
    Creato il 20 apr 2006
    Consegnato il 05 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 apr 2006
    Consegnato il 05 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 18/04/06 and
    Creato il 20 mar 2006
    Consegnato il 22 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the claymore hotel (formerly the cobbler hotel) arrochar t/no DMB19886.
    Persone aventi diritto
    • Jewel Hotels Trustee I Limited and Jewel Hotels Trutee Ii Limited as Trustees of the Jewelhotel
    Transazioni
    • 22 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming the fife arms hotel, braemar, aberdeenshire (formerly the cobbler hotel) arrochar, t/n DMB19886. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Indigo Capital Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming the fife arms hotel, braemar, aberdeenshire, t/n ABN50574. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Indigo Capital Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming the fife arms hotel, braemar, aberdeenshire, t/n ABN50574. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 24 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming the claymore hotel (formerly the cobbler hotel) arrochar, t/n DMB19886. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 march 2005 and
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 13 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects known as and forming the fife arms hotel braemar aberdeenshire t/n ABN50574.
    Persone aventi diritto
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 13 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 24 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 march 2005 and
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 13 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects forming the claymore hotel (formerly the cobbler hotel) arrochar t/n DMB19886.
    Persone aventi diritto
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 13 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 31 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Indigo Capital Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 31 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 31 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 31 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 30 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 18 september 2003 and
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 25 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole the property known as and forming the cobbler hotel, arrochar, scotland t/no DMB19886.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 15 october 2001 and
    Creato il 02 ott 2001
    Consegnato il 19 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and in terms of a facility letter and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brevi particolari
    The fife arms hotel braemar (ABN50574).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 15 october 2001 and
    Creato il 02 ott 2001
    Consegnato il 19 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and in terms of a facility letter and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brevi particolari
    0.40 acres at broombank terrace braemar (AB50572). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of key-man policies
    Creato il 02 ott 2001
    Consegnato il 18 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite cross guarantee and mortgage debenture
    Creato il 02 ott 2001
    Consegnato il 18 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite cross guarantee and mortgage debenture
    Creato il 02 ott 2001
    Consegnato il 18 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 30 july 2001 and
    Creato il 13 lug 2001
    Consegnato il 03 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facilities agreement (as defined) dated 15 august 1997 and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brevi particolari
    0,40 acres at broombank terrace, braemar, aberdeenshire (ABN50572). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 03 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 30 july 2001 and
    Creato il 13 lug 2001
    Consegnato il 03 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facilities agreement (as defined) dated 15 august 1997 and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brevi particolari
    The fife arms hotel, braemar, aberdeenshire (ABN50574). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 03 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 july 2001 and
    Creato il 13 lug 2001
    Consegnato il 03 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facility letter (as defined) and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brevi particolari
    0.40 acres at broombrook terrace, braemar, aberdeenshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 03 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 july 2001 and
    Creato il 13 lug 2001
    Consegnato il 03 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facility letter (as defined) and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brevi particolari
    The fife arms hotel, braemar, aberdeenshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 03 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A charge over shares between the company and barclays bank PLC (the "security trustee")
    Creato il 09 feb 2001
    Consegnato il 28 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by any company in the wallace arnold group to the security trustee and/or the beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    27,000 ordinary shares of £1.00 each in perfect holidays limited and all dividends interest and other distributions.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A charge over shares
    Creato il 26 gen 2001
    Consegnato il 07 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee and/or the beneficiaries on any account whatsoever pursuant to the banking agreements (as defined)
    Brevi particolari
    All the shares,dividends,and bonus issues. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 18TH march 1999 and
    Creato il 05 mar 1999
    Consegnato il 24 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    25 high st,bonnyrigg,county of midlothian with all rights,pertinents,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    COACH HOLIDAY GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 mag 2020Inizio della liquidazione
    09 mag 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0