ABET INTERNATIONAL LIMITED

ABET INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABET INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03354186
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABET INTERNATIONAL LIMITED?

    • Altra istruzione n.c.a. (85590) / Istruzione

    Dove si trova ABET INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABET INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ABET - SLOVAKIA LIMITED12 mag 199712 mag 1997
    INHOCO 619 LIMITED17 apr 199717 apr 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABET INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ABET INTERNATIONAL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ABET INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da * the Old Vicarage Market Street Castle Donington Derbyshire DE74 2JB United Kingdom* in data 13 giu 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ott 2012

    Stato del capitale al 18 ott 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Fitzmaurice il 11 ott 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Graeme Robert Halder il 11 ott 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 ago 2011

    16 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * the Old Vicarge Market Place Castle Donington Derbyshire DE74 2JB United Kingdom* in data 21 mag 2012

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    Indirizzo della sede legale modificato da * Nord House Third Avenue Centrum 100 Burton-upon-Trent Staffordshire DE14 2WD* in data 16 apr 2012

    1 pagineAD01

    legacy

    21 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 ago 2010

    17 pagineAA

    Nomina di Mr Graeme Robert Halder come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Smith come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 ago 2009

    17 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Fitzmaurice il 29 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Fitzmaurice il 29 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 ago 2008

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ABET INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FITZMAURICE, Andrew
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Amministratore
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Hong KongBritishChief Executive70922490005
    HALDER, Graeme Robert
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Amministratore
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Hong KongBritishFinance Director154739000003
    HYDE, Stephen
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    BritishCompany Director73116190002
    HYDE, Stephen
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    BritishCompany Director73116190002
    METCALF, Hannah Ruth
    Addleshaw Goddard
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Lancashire
    Segretario
    Addleshaw Goddard
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Lancashire
    British114415480001
    SIMPSON, Lorene
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    Segretario
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director51283590002
    SMITH, David Andrew Gordon
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishFinance Director124619670001
    TARN, Elizabeth Jill
    Flat 10 Rosemount House
    15a Poplar Road Dorridge
    B93 8DD Solihull
    Segretario
    Flat 10 Rosemount House
    15a Poplar Road Dorridge
    B93 8DD Solihull
    British92051440005
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    HYDE, Stephen
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    BritishCompany Director73116190002
    JOHNSON, David William
    Jolly Hall Farm
    Oakenhead Wood Old Road
    BB4 8TX Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    Jolly Hall Farm
    Oakenhead Wood Old Road
    BB4 8TX Rossendale
    Lancashire
    BritishCompany Director2299140002
    MARSHALL, Rosamund Margaret
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    BritishChief Operating Officer87585160002
    MCNEANY, Kevin Joseph
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    EnglandIrishCompany Director2299150001
    SIMPSON, Lorene
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director51283590002
    SMITH, David Andrew Gordon
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishFinance Director124619670001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    ABET INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 mar 2012
    Consegnato il 10 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp International Limited,as Security Agent
    Transazioni
    • 10 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Accession deed
    Creato il 10 ott 2008
    Consegnato il 28 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, Singapore Branch (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 28 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 25 giu 2007
    Consegnato il 28 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 21 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 21 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 nov 1998
    Consegnato il 28 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 28 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 nov 1997
    Consegnato il 13 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ABET INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    2
    DataTipo
    28 mag 2013Inizio della liquidazione
    30 ott 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0