ALLIGATOR STORAGE LTD.

ALLIGATOR STORAGE LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALLIGATOR STORAGE LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03356309
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    • Operazione di strutture di stoccaggio e deposito per attività di trasporto via terra (52103) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Brittanic House
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Hertfordshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KEEPSAFE LIMITED10 set 199710 set 1997
    LAWGRA (NO.422) LIMITED18 apr 199718 apr 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 nov 2019

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 nov 2018

    LRESSP

    Cessazione della carica di Sam Ahmed come segretario in data 30 set 2018

    1 pagineTM02

    Bilancio modificato per una piccola impresa redatto al 30 set 2015

    17 pagineAAMD

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 set 2018

    • Capitale: GBP 1.48
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ott 2017

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2017 al 31 ott 2017

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Rajveer Ranawat come amministratore in data 01 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Akbar Abdul Rafiq come amministratore in data 01 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Diego Arroyo come amministratore in data 01 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Frederico Oliva come amministratore in data 01 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mehran Charania come amministratore in data 01 nov 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 033563090018 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 033563090020 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 033563090017 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 033563090019 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Andrew Brian Jones come amministratore in data 01 nov 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Andrew Brian
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    EnglandEnglish178066050001
    VECCHIOLI, Federico
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    EnglandFrench158800170002
    AHMED, Sam
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    Segretario
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    239675980001
    SMYTH, Michael Anthony
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    Segretario
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    British4337440001
    GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Segretario
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC287766
    110304810001
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Segretario nominato
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    ARROYO, Diego
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    Amministratore
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    EnglandMexican192493040001
    BAILLIE, Mark William
    Little Stream
    Woodlands Road West
    GU25 4PN Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Little Stream
    Woodlands Road West
    GU25 4PN Virginia Water
    Surrey
    Australian112156520002
    CARPENTER, Malcolm Edward
    100 Pennycress Way
    MK16 8TT Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    100 Pennycress Way
    MK16 8TT Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British115886430001
    CHARANIA, Mehran
    Dorset Street
    W1V 6QU London
    11 Bryanston House
    United Kingdom
    Amministratore
    Dorset Street
    W1V 6QU London
    11 Bryanston House
    United Kingdom
    United KingdomBelgian104274770001
    CLARKE, Christine
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    Amministratore
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    British138932540001
    CLEGG, Michael Bailey
    Upwey 36 Old Turnpike
    PO16 7HA Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    Upwey 36 Old Turnpike
    PO16 7HA Fareham
    Hampshire
    British57300000001
    EDGE, Roderick Boris Clifford
    The Water Tower Knoll Road
    GU7 2EJ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    The Water Tower Knoll Road
    GU7 2EJ Godalming
    Surrey
    SurreyBritish15622690001
    HODGSON, Simon Squair
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish89025200003
    JACK, Alister William
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    Amministratore
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    ScotlandBritish159211330001
    JEFFREY, Alexander Daniel
    Ainger Road
    NW 3AH London
    46a
    Amministratore
    Ainger Road
    NW 3AH London
    46a
    United KingdomBritish129962520001
    LANDALE, Peter David Roper
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    Amministratore
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United KingdomBritish49635220001
    LUCCIONI, Laurent Xavier
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    Amministratore
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    United KingdomFrench131705720001
    OLIVA, Frederico
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    Amministratore
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    United KingdomItalian192498980001
    PERUSAT, Marc Michel
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Amministratore
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    United KingdomFrench115589250001
    PULIDO, Rena
    125 W Delaware Place
    FOREIGN Chicago
    Illinois Il 60610
    United States
    Amministratore
    125 W Delaware Place
    FOREIGN Chicago
    Illinois Il 60610
    United States
    Australian122049340001
    RAFIQ, Akbar Abdul Aziz
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    Amministratore
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    EnglandBritish,Pakistani192308760001
    RANAWAT, Rajveer
    Chatsworth Road
    Cricklewood
    NW2 4BT London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Chatsworth Road
    Cricklewood
    NW2 4BT London
    40
    United Kingdom
    EnglandBritish179208350001
    SANTER, Christopher John
    Jedburgh Street
    Clapham
    SW11 5QB London
    6
    Amministratore
    Jedburgh Street
    Clapham
    SW11 5QB London
    6
    EnglandBritish128404730001
    SMITH, Nathan Robert
    England's Lane
    NW3 4YD London
    41b
    United Kingdom
    Amministratore
    England's Lane
    NW3 4YD London
    41b
    United Kingdom
    Australian136694070001
    SMITH, Nathan Robert
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Amministratore
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Australian123776780001
    SMYTH, Michael Anthony
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    Amministratore
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    EnglandBritish4337440001
    STREET, Stephen Gregory
    10 English Street
    Mile End
    E3 4TA London
    United Kingdom
    Amministratore
    10 English Street
    Mile End
    E3 4TA London
    United Kingdom
    British47656020001
    TAYLOR, Michael James
    Stanley Hill Ave
    Amersham
    HP7 9BB London
    39
    United Kingdom
    Amministratore
    Stanley Hill Ave
    Amersham
    HP7 9BB London
    39
    United Kingdom
    Australian128209530001
    WILKINSON, Charles Edmund
    Utopia
    Rue De La Passee
    GY2 4TN St Sampsons
    Channel Islands
    Amministratore
    Utopia
    Rue De La Passee
    GY2 4TN St Sampsons
    Channel Islands
    GuernseyBritish127529840001
    WONG, Lilian
    Martin Place
    2000 Syndney
    1
    New South Wales
    Australia
    Amministratore
    Martin Place
    2000 Syndney
    1
    New South Wales
    Australia
    Australian139160950001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Storage Uk Spv1 Ltd
    Duke Street
    W1U 1LN London
    3rd Floor 37 Duke Street
    England
    06 apr 2016
    Duke Street
    W1U 1LN London
    3rd Floor 37 Duke Street
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom Company Law
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione06271294
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    ALLIGATOR STORAGE LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 dic 2014
    Consegnato il 05 dic 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 05 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 ott 2014
    Consegnato il 29 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    T/Nos WM742950 BL82345 SY291399 BD255255 NT329242 HP116380 and HP700117.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transazioni
    • 29 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 ott 2014
    Consegnato il 29 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transazioni
    • 29 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 ott 2014
    Consegnato il 28 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transazioni
    • 28 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 07 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 03 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a honeygrove house bond street southampton t/n HP116380.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 03 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a sunbury house farnham trading estate farnham t/no SY291399.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 03 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/A property k/a unit 9 freshfield industrial estate kemp town brighton t/no ESX285601 ESX340864.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 03 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a woodhall underground garages robert street london.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 03 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 214 - 224 broomhill road bristol t/no BL82345.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 03 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 20 moorside road winchester t/no HP700117.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 03 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 12 cosgrove way luton t/no BD255255.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 03 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings at bath street tec nottingham t/no NT329242.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 03 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land and buildings on the north side of garretts green lane sheldon birmingham t/no WM742950.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2010
    Consegnato il 09 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due form each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery for details of properties charged please refer to form MG01 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 10 gen 2008
    Consegnato il 14 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sunbury house farnham trading estate farnham t/n SY291399,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 14 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 08 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 29 nov 2005
    Consegnato il 02 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The standard and double ender 20' containers with the following unit/series numbers ornu 301345 ornu 301256 ornu 300623 for further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ago 2000
    Consegnato il 05 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 1998
    Consegnato il 22 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bath street tec nottingham nottinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ALLIGATOR STORAGE LTD. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 nov 2018Inizio della liquidazione
    07 mar 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Sherry
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0