MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED

MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03358076
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MINERVA PROPERTY HOLDINGS PLC12 giu 199712 giu 1997
    TRADEFIGURE PUBLIC LIMITED COMPANY22 apr 199722 apr 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 mag 2020

    12 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 mag 2019

    11 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 mag 2018

    10 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Colin Barry Wagman come amministratore in data 29 mar 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Jonathan Goswell come amministratore in data 29 mar 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da 40 Queen Anne Street London W1G 9EL a 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE in data 08 giu 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 mag 2017

    LRESSP

    Cessazione della carica di Michael George Cohen come amministratore in data 05 apr 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Anthony Piper come amministratore in data 05 apr 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    18 pagineAA

    Stato del capitale al 27 set 2016

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Michael George Cohen come amministratore in data 28 lug 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr James Anthony Piper come amministratore in data 28 lug 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Holroyd come amministratore in data 28 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Anthony Piper come amministratore in data 28 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Jonathan Goswell come amministratore in data 28 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael George Cohen come amministratore in data 28 lug 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    United Kingdom
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector202597650001
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    BritishDirector56155670004
    KLEINER, Richard Howard
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    Segretario
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    British29866240002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLEE, Rodney
    7 Boxworth Close
    North Finchley
    N12 9HJ London
    Amministratore
    7 Boxworth Close
    North Finchley
    N12 9HJ London
    BritishAccountant53537100002
    CHERRY, Mark Christopher
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector69114260002
    COHEN, Michael George
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    United Kingdom
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant153509790001
    COHEN, Michael George
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant153509790001
    COSTER, Paul Antony
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    BritishCompany Director35406400003
    DARE, Cliff Roderick Stanton
    Little Manor House
    Bell Hill Hook Norton
    OX15 5NG Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Little Manor House
    Bell Hill Hook Norton
    OX15 5NG Banbury
    Oxfordshire
    BritishCompany Director79899690001
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director56155670004
    GARNHAM, Timothy Claude
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector66502160002
    GARRARD, David Eardley, Sir
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    Amministratore
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    EnglandBritishCompany Director76373440001
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor
    Uk
    Amministratore
    Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor
    Uk
    United KingdomBritishDirector60475780003
    HASAN, Salmaan
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector106868320001
    HIGSON, John Anthony
    White Gates
    White Cross Zeals
    BA12 6PH Warminster
    Wilts
    Amministratore
    White Gates
    White Cross Zeals
    BA12 6PH Warminster
    Wilts
    BritishProperty Investment31661220002
    HOLROYD, Peter
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector111330930001
    LAMONT, Alexander Wilson
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor
    Uk
    Amministratore
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor
    Uk
    EnglandBritishDirector158518680001
    MOODY, Edward Robert William
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Great BritainBritishDirector62122950001
    MORRIS, Alexander
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector110589420002
    PIPER, James Anthony
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management
    United Kingdom
    Amministratore
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director, Real Estate Investment163685440001
    PIPER, James Anthony
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    Amministratore
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    EnglandBritishManaging Director, Real Estate Investment163685440001
    RIXON, Arthur John
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    BritishDirector40591390002
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    Amministratore
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBritishCompany Director118467060001
    THOMPSON, Quentin Charles
    17 Graemsdyke Avenue
    East Sheen
    SW14 7BH London
    Amministratore
    17 Graemsdyke Avenue
    East Sheen
    SW14 7BH London
    EnglandBritishCompany Director33552230002
    WAGMAN, Colin Barry
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6h Floor, Lansdowne House
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6h Floor, Lansdowne House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant189915990001
    YEWMAN, Steven John
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector45742320002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Amministratore delegato nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Minerva Limited
    Queen Anne Street
    W1G 9EL London
    40
    England
    06 apr 2016
    Queen Anne Street
    W1G 9EL London
    40
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies England And Wales
    Numero di registrazione02649607
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Third party charge on shares
    Creato il 05 feb 2008
    Consegnato il 09 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from M1 limited or the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge its interest in (a) the investments; and (b) all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of such investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Trustee for the Beneficiaries (The "Agent")
    Transazioni
    • 09 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third party legal charge
    Creato il 16 nov 2006
    Consegnato il 22 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H 111 cannon street london t/n LN190165. 103 cannon street london t/n NGL822949. F/h 13 st. Swithin's lane, london t/n ngl 558962 (for details of further properties charged please see form 395) and fixed charge its interest in the investments and all dividends interest and other money payable in respect of such investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch (The "Agent")
    Transazioni
    • 22 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Third party charge on shares
    Creato il 27 lug 2006
    Consegnato il 04 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge its interest in the investments and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of such investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag London Branch as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 04 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Third party charge on shares
    Creato il 28 mar 2006
    Consegnato il 08 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers or the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The investments and all dividends interest and other money in respect of such investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch as Trustee for the Beneficiaries (The Agent)
    Transazioni
    • 08 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Third party charge on shares
    Creato il 30 gen 2006
    Consegnato il 07 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or the borrowers to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee by way of fixed charge the investments and all dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag London Branch as Trustee for the Beneficiaries (The Agent)
    Transazioni
    • 07 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of guarantee and security deposit
    Creato il 25 nov 2005
    Consegnato il 10 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Deposit in the amount of £2,350,000 held in an account.
    Persone aventi diritto
    • Odeon Cinemas Limited
    Transazioni
    • 10 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party charge on shares
    Creato il 25 nov 2005
    Consegnato il 03 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers and the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge its interest in the investments and all dividends, interest and other money payable in respect of such investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch as Trustee for the Beneficiaries (The Agent)
    Transazioni
    • 03 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on shares
    Creato il 05 dic 2003
    Consegnato il 20 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from hutch investments limited and chainbill limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money payable.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bhf-Bank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 20 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 10 giu 2002
    Consegnato il 15 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The investments and any dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 15 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 25 feb 2002
    Consegnato il 06 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A). all shares held by the chargor in the borrower from time to time being at the date of the charge over shares, 2 ordinary shares of £1 each in the borrower held by the chargor which comprise 100% of the issued share capital of the borrower (the "shares") b). I). any dividends distributions or other income from time to time declared paid or made on any of the shares ii). All voting rights in respect of any of the shares iii). And all other benefits money rights or other assets from time to time accruing arising in respect of any of the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 06 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 11 mag 2000
    Consegnato il 17 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All or any of the present or future or actual or contingent obligations or liabilities due or to become due from M1 limited and/or minerva (ambassador) limited to the chargee or the beneficiaries (as defined) under any finance document (as defined) or under the charge
    Brevi particolari
    2 ordinary shares of £1.00 each in M1 limited and 2 ordinary shares of £1.00 each in minerva (ambassador) limited and all dividends interest and other monies payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 20 mar 2000
    Consegnato il 25 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present or future obligations or liabilities of gradegilt limited to the beneficiaries under the finance documents and all liabilities of the chargor under the debenture (all defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed charge any investment issued by way of redemption bonus preference option or otherwise in respect of any investment and all dividends interest and other monies payable to the chargor in respect of any charged investment.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 25 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creato il 09 dic 1998
    Consegnato il 17 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement and/or in connection with the facility thereby granted and/or under the charge or any other security document (as defined in the loan agreement) (the obligations)
    Brevi particolari
    Right title and interest in and to two ordinary shares and all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Ag
    Transazioni
    • 17 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 12 mar 1998
    Consegnato il 21 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All or any of the present or future or actual or contingent obligations or liabilities due or to become due from the company to the chargee or the beneficiaries (as defined) under any finance document (as defined) or under the charge
    Brevi particolari
    100 ordinary shares of £1.00 each issued by the company and all dividends interest and other monies payable.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 21 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 30 giu 1997
    Consegnato il 11 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to the beneficiaries (as defined) arising under or in connection with the guarantee dated 19TH july 1996 and/or minerva PLC under the finance documents (as defined) whether or not originally owed to the beneficiaries and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The whole of its both present and future and wheresoever and wheresoever situate for the angelmist shares and the premier land shares. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    Transazioni
    • 11 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares (twin tower)
    Creato il 30 giu 1997
    Consegnato il 11 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from angelmist limited to the chargee and the beneficiaries under the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Its 99 ordinary shares in twin tower properties limited together with the one share it holds jointly with andrew ian rosenfeld; any investment issued by way of redemption, bonus, preference option or otherwise in respect of any investment referred to above and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    Transazioni
    • 11 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares (helios)
    Creato il 30 giu 1997
    Consegnato il 11 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from helios property investments limited to the chargee and the beneficiaries under the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Its 2 ordinary shares in helios; any investment issued by way of redemption bonus preference option or otherwise in respect of any investment referred to above and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    Transazioni
    • 11 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares (angelmist)
    Creato il 30 giu 1997
    Consegnato il 11 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from angelmist limited to the chargee and to the beneficiaries under the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Its 2 ordinary shares in angelmist; any investment issued by way of redemption, bonus, preference, option or otherwise in respect of any investment referred to above; and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    Transazioni
    • 11 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 30 giu 1997
    Consegnato il 11 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to the beneficiaries arising under the guarantee and/or minerva PLC to the beneficiaries arising under or in connection with the finance documents whether not originally owed to the beneficiaries and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any investment in any guarantors (excluding twin tower) and any investment issued by way of redemption bonus preference option or otherwise in respect of any investment referred to above.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    Transazioni
    • 11 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MINERVA PROPERTY HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 mag 2017Inizio della liquidazione
    24 dic 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Praticante
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0