TOOTHILL PHARMACY LTD

TOOTHILL PHARMACY LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOOTHILL PHARMACY LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03362875
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOOTHILL PHARMACY LTD?

    • Farmacia al dettaglio in negozi specializzati (47730) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova TOOTHILL PHARMACY LTD?

    Indirizzo della sede legale
    L Rowland & Co (Retail) Ltd Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOOTHILL PHARMACY LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WATLINGTON PHARMACY LTD11 dic 200111 dic 2001
    THAMES VALLEY CHEMISTS LIMITED01 mag 199701 mag 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOOTHILL PHARMACY LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per TOOTHILL PHARMACY LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 ott 2018

    • Capitale: GBP 10
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 033628750012 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione di John Gerard Patrick D'arcy come persona con controllo significativo il 31 gen 2018

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2018

    3 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ott 2017 al 31 gen 2018

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Stephen William Anderson come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Jonathan Smith come amministratore in data 01 ott 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Ian Campbell Cowan come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC01

    Notifica di John D'arcy come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC01

    Notifica di Margaret Elizabeth Macrury come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC01

    Notifica di Kenneth John Black come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC01

    Notifica di Jill Chiwara come persona con controllo significativo il 01 ott 2016

    2 paginePSC01

    Bilancio redatto al 31 ott 2016

    19 pagineAA

    Cessazione di Paul Jonathan Smith come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC07

    Cessazione di Kevin Robert Hudson come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC07

    Cessazione di Michael Peter Blakeman come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2016 con aggiornamenti

    9 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di TOOTHILL PHARMACY LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLAKEMAN, Michael Peter
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    England
    Segretario
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    England
    203003130001
    ANDERSON, Stephen William
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    Amministratore
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    EnglandBritish215485900001
    HUDSON, Kevin Robert
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Instate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Instate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    England
    EnglandBritish69091720002
    ARTURI, Angelina Grace
    69 Hatch Ride
    RG45 6LF Crowthorne
    Berkshire
    Segretario
    69 Hatch Ride
    RG45 6LF Crowthorne
    Berkshire
    British99202570001
    THOMAS, Richard Hugh
    69 Hatch Ride
    RG45 6LF Crowthorne
    Berkshire
    Segretario
    69 Hatch Ride
    RG45 6LF Crowthorne
    Berkshire
    British73578420002
    APEX COMPANY SERVICES LIMITED
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    Segretario nominato
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    900004340001
    APEX COMPANY SERVICES LIMITED
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    Segretario nominato
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    900004340001
    JONES, Arthur Graham Baylis
    7 Court Road
    Letcombe Regis
    OX12 9JH Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    7 Court Road
    Letcombe Regis
    OX12 9JH Wantage
    Oxfordshire
    EnglandBritish31461000002
    JONES, Julie Elizabeth
    7 Court Road
    Letcombe Regis
    OX12 9JH Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    7 Court Road
    Letcombe Regis
    OX12 9JH Wantage
    Oxfordshire
    EnglandBritish31460990002
    SMITH, Paul Jonathan
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Instate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Instate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    England
    WalesBritish63118770002
    THOMAS, Richard Hugh
    69 Hatch Ride
    RG45 6LF Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    69 Hatch Ride
    RG45 6LF Crowthorne
    Berkshire
    United KingdomBritish73578420002
    APEX NOMINEES LIMITED
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    Amministratore delegato nominato
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    900004330001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TOOTHILL PHARMACY LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Jill Chiwara
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    01 ott 2016
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Scotland
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr John Gerard Patrick D'Arcy
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    06 apr 2016
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Kevin Robert Hudson
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    06 apr 2016
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Michael Peter Blakeman
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    06 apr 2016
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Paul Jonathan Smith
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    06 apr 2016
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Wales
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Rowlands Pharmacy
    Cheshire
    England
    06 apr 2016
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Rowlands Pharmacy
    Cheshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2288928
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Mr Ian Campbell Cowan
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    06 apr 2016
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Scotland
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Kenneth John Black
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    06 apr 2016
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Wales
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Ms Margaret Elizabeth Macrury
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    06 apr 2016
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    L Rowland & Co (Retail) Ltd
    Cheshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    TOOTHILL PHARMACY LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 ago 2015
    Consegnato il 04 ago 2015
    In corso
    Breve descrizione
    Toothill pharmacy, dunwich drive, swindon, SN5 8SX registered at the land registry with title number WT296148.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 ago 2015
    Consegnato il 04 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 dic 2012
    Consegnato il 17 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC as Security Trustee ("Security Holder") for Each Group Member
    Transazioni
    • 17 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 ott 2008
    Consegnato il 16 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Alliance & Leicester PLC
    Transazioni
    • 16 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third party legal charge
    Creato il 02 lug 2007
    Consegnato il 18 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from swindon pharmacies limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    60 high street chalgrove oxford.
    Persone aventi diritto
    • Alliance & Leicester PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third party legal charge
    Creato il 01 mag 2007
    Consegnato il 09 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from swindon pharmacies limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    54 couching street watlington oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Alliance & Leicester PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 dic 2005
    Consegnato il 14 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H 60 high street chalgrove oxon and the plan furniture equipment.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transazioni
    • 14 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 ott 2003
    Consegnato il 25 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transazioni
    • 25 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 2003
    Consegnato il 25 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property watlington pharmacy, market place, watlington, oxfordshire and any part or parts of it and including all rights attached or appurtenant to it and all buildings fixtures and fittings plant and machinery, the company's beneficial interest in the property or the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transazioni
    • 25 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 ago 2003
    Consegnato il 29 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a market place, watlington, oxford OX49 5PU and proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aah Pharmaceuticals Limited, Barclay Pharmaceuticals Limited and Farillon Limited
    Transazioni
    • 29 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 lug 2002
    Consegnato il 20 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 mag 1998
    Consegnato il 19 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a the pharmacy market place watlington oxfordshire.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 18 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0