HI FINANCE PROPERTIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HI FINANCE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03363702 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
- Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HOLIDAY INN FINANCE PROPERTIES LIMITED | 16 lug 2002 | 16 lug 2002 |
| COMPASS HOTEL PROPERTIES LIMITED | 31 gen 2001 | 31 gen 2001 |
| GRANADA HOTEL PROPERTIES LIMITED | 26 set 1997 | 26 set 1997 |
| 2036TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED | 01 mag 1997 | 01 mag 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 17 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 nov 2018 | 16 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Justin Bruce Robinson come amministratore in data 14 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 21 dic 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Haysmacintyre Company Secretaries Limited il 18 dic 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Bruce Robinson il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Michael Teasdale il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG in data 18 dic 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Thomas Mabry il 18 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 033637020006 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 20 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 03 ott 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 033637020006 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Bruce Robinson il 03 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Amministratore | Little New Street EC4A 3TR London Hill House 1 | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Amministratore | Little New Street EC4A 3TR London Hill House 1 | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Segretario | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Segretario | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Segretario | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203651900001 | |||||||||||
| MASON, Timothy Charles | Segretario | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Segretario | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Segretario | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Segretario | Bishops Square Eighth Floor E1 6EG London Ten United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| SISEC LIMITED | Segretario nominato | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Stacey Lee | Amministratore | 46 Chiddingstone Road SW6 3TG London | British | 37682070002 | ||||||||||
| CROSTON, Francis John | Amministratore | 5 The Laurels Queenborough Lane CM77 7QD Braintree Essex | United Kingdom | British | 65219360003 | |||||||||
| DAVENPORT, Donald Andrew | Amministratore | Ramsbury House 23 Badgers Hill Wentworth GU25 4SA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 13178710003 | |||||||||
| DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Amministratore | Cuckoo Meadow Little Shardeloes HP7 0EF Old Amersham Buckinghamshire | England | British | 100598030001 | |||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Amministratore | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Amministratore | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Amministratore | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MACKENZIE, Lisa Marie | Amministratore | 70 Vassall Road Kennington SW9 6HY London | British | 78059700001 | ||||||||||
| MARTIN, Andrew David | Amministratore | 5 Dalkeith Road AL5 5PP Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 52743800001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Amministratore | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Amministratore | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| MITCHELL, Paul Raymond | Amministratore | Waltons Farm Hollygreen Lane HP27 9PL Bledlow Bucks England | England | British | 148147140001 | |||||||||
| MORTIMER, David Grant | Amministratore | 86 Frenchay Road OX2 6TF Oxford Oxfordshire | British | 47770480002 | ||||||||||
| NEWMAN, Mark | Amministratore | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PARROTT, Graham Joseph | Amministratore | Flat 1 27 Redington Road Hampstead NW3 7QY London | British | 6741720003 | ||||||||||
| PRINCE, Ryan David | Amministratore | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 | |||||||||
| ROBINSON, Justin Bruce | Amministratore | Little New Street EC4A 3TR London Hill House 1 | United Kingdom | British | 225299130001 | |||||||||
| SPRINGETT, Catherine Mary | Amministratore | The Coach House 32 Kerrison Road Ealing W5 5NW London | United Kingdom | British | 147336720001 | |||||||||
| STAUNTON, Henry Eric | Amministratore | Fairfield Nursery Road KT20 7TZ Walton On The Hill Surrey | England | British | 37935500001 | |||||||||
| STOCKS, Nigel Peter | Amministratore | Birdwoods School Lane Shackleford GU8 6AZ Godalming Surrey | United Kingdom | British | 147336730001 | |||||||||
| STRETTON, Mark Nigel | Amministratore | Top Cottage Upper Oddington GL56 0XN Moreton-In-Marsh | British | 95909440001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nas Cobalt No.2 Limited | 06 apr 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HI FINANCE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 01 dic 2015 Consegnato il 02 dic 2015 | In corso | ||
Breve descrizione F/H crest hotel filton road hambrook t/no.AV194979 and l/h the bloomsbury crest hotel coram stret t/no.NGL672413. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 22 mag 2013 Consegnato il 03 giu 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione F/H basingstoke crest hotel grove road basingstoke t/no HP409818, f/h black prince hotel southwold road bexley t/no SGL103988, f/h crest hotel filton road hambrook t/no AV194979, for details of further properties charged please refer to the form MR01. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 20 giu 2005 Consegnato il 28 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 giu 2005 Consegnato il 22 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 241097 | Creato il 24 ott 1997 Consegnato il 07 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The erskine crest hotel erskine renfrew t/n REN57421. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 ott 1997 Consegnato il 29 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from granada group PLC to the chargee pursuant to the terms of the loan agreement of even date together with any other monies payable by the company to the chargee under the legal charge | |
Brevi particolari Basingstoke posthouse (formerly basingstoke crest hotel) basingstoke hampshire T.no: HP409818; bexley posthouse (formerly k/a black prince public house) rochester way l/b of bexley t/no: SGL103988; bristol posthouse (formerly crest hotel) filton house hambrrok south gloucestershire t/no: AV194979. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
HI FINANCE PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0