CALLCENTRIC LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CALLCENTRIC LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03367572 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CALLCENTRIC LIMITED?
- Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione
Dove si trova CALLCENTRIC LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1000 Great West Road Brentford TW8 9HH Middlesex |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di CALLCENTRIC LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per CALLCENTRIC LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Brent Austin Marshall come amministratore in data 13 set 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Kent come amministratore in data 13 set 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Brent Austin Marshall come segretario in data 13 set 2013 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Kent il 01 nov 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Brent Austin Marshall come segretario in data 19 mar 2012 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Brent Austin Marshall come amministratore in data 19 mar 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Jon Andrew Victor Sopher come amministratore in data 14 dic 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Alan Wingfield come amministratore in data 04 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CALLCENTRIC LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPHER, Jon Andrew Victor | Amministratore | 1000 Great West Road Brentford TW8 9HH Middlesex | United Kingdom | British | 58720360003 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Segretario | Norwich Street EC4A 1BD London 10 | British | 38963210007 | ||||||
| HARRIS, Philip Bernard | Segretario | 85 Western Road Ealing W5 5DT London | British | 54037970002 | ||||||
| LEWIS, Paul Raymond Thomas | Segretario | 11 Wellfield Gardens SM5 4EA Carshalton Beeches Surrey | British | 147923250001 | ||||||
| MARSHALL, Brent Austin | Segretario | 1000 Great West Road Brentford TW8 9HH Middlesex | 167691820001 | |||||||
| WINGFIELD, Richard Alan | Segretario | Town Farm Close OX9 2DA Thame 1 Oxfordshire | 149795610001 | |||||||
| BANNER & ASSOCIATES LTD | Segretario nominato | 29 Byron Road HA1 1JR Harrow Middlesex | 900011090001 | |||||||
| BEYNSBERGER, David | Amministratore | 6 Coombe Hill Court SL4 4UL Windsor Berkshire | British | 52160540001 | ||||||
| CLARK, Robert Ian | Amministratore | 25 Carpenders Close AL5 3HN Harpenden Hertfordshire | British | 78415290002 | ||||||
| FAUX, Sarah | Amministratore | 3 Glenmore House Richmond Hill TW10 6BQ Richmond Surrey | British | 84672680001 | ||||||
| HARRIS, Philip Bernard | Amministratore | 85 Western Road Ealing W5 5DT London | United Kingdom | British | 54037970002 | |||||
| KENT, James | Amministratore | 1000 Great West Road Brentford TW8 9HH Middlesex | United Kingdom | British | 148367460001 | |||||
| LANGMORE, Michael | Amministratore | 28 Russell Road HA6 2LR Northwood Middlesex | England | British | 11172280001 | |||||
| LEWIS, Paul Raymond Thomas | Amministratore | 11 Wellfield Gardens SM5 4EA Carshalton Beeches Surrey | United Kingdom | British | 147923250001 | |||||
| MARSHALL, Brent Austin | Amministratore | Southdowns The Avenue Clifton BS8 3GE Bristol Flat 7 United Kingdom | England | British | 167689850001 | |||||
| OLISA, Kenneth Aphunezi, Sir | Amministratore | 18 Glamorgan Road Hampton Wick KT1 4HP Kingston Upon Thames Surrey | England | British | 31705700001 | |||||
| PARKER, Nicholas | Amministratore | Crome Hill Ashridge Park HP4 1NP Berkhamsted Hertfordshire | British | 70897450001 | ||||||
| PORTLOCK, Michael Kenneth | Amministratore | Skimbleshanks Hook Heath Road GU22 0LE Woking Surrey | British | 63903230001 | ||||||
| RANSOM, Graham Richard | Amministratore | 8 Fairacre Woolton Hill RG20 9UF Newbury Berkshire | Uk | British | 34690210001 | |||||
| ROGERS, Derek | Amministratore | 42 Belvedere Road SE19 2HW London | England | British | 73548000001 | |||||
| TAILOR, Pravin | Amministratore | Chess Way Chorley Wood WD3 5TA Rickmansworth Fairwinds Hertfordshire | United Kingdom | British | 23960250003 | |||||
| VITHALDAS, Vim | Amministratore | 6 The Chase Great Amwell SG12 9TN Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | 59433340003 | |||||
| WINGFIELD, Richard Alan | Amministratore | Town Farm Close Thame OX9 2DA Oxford 1 Oxon | England | British | 76932830002 | |||||
| BANNER NOMINEES LTD | Amministratore delegato nominato | 29 Byron Road HA1 1JR Harrow Middlesex | 900011080001 |
CALLCENTRIC LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission | Creato il 09 mar 2007 Consegnato il 19 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The credit balance being any sum standing to the credit of an account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Omnibus guarantee & set off agreement | Creato il 02 mar 2007 Consegnato il 12 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company charges under the agreement its credit balances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 02 mar 2007 Consegnato il 12 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 08 mar 2004 Consegnato il 15 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more companies including any accounts in the banks name with any designation which includes the names of the companies or any one or more of the companies. (The accounts). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 06 gen 2003 Consegnato il 17 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any one or more of the companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more companies including any accounts in the bank name with any designation which includes the name of the companies or any one or more of the companies.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 05 set 2002 Consegnato il 25 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any principal debtor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 nov 1998 Consegnato il 01 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 lug 1997 Consegnato il 23 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0