CALLCENTRIC LIMITED

CALLCENTRIC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCALLCENTRIC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03367572
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CALLCENTRIC LIMITED?

    • Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova CALLCENTRIC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CALLCENTRIC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per CALLCENTRIC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Brent Austin Marshall come amministratore in data 13 set 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Kent come amministratore in data 13 set 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Brent Austin Marshall come segretario in data 13 set 2013

    1 pagineTM02

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG United Kingdom

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 mag 2013

    Stato del capitale al 10 mag 2013

    • Capitale: GBP 82,052.14
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Kent il 01 nov 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Brent Austin Marshall come segretario in data 19 mar 2012

    1 pagineAP03

    Nomina di Mr Brent Austin Marshall come amministratore in data 19 mar 2012

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011

    2 pagineAA

    Nomina di Mr Jon Andrew Victor Sopher come amministratore in data 14 dic 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Alan Wingfield come amministratore in data 04 nov 2011

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CALLCENTRIC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SOPHER, Jon Andrew Victor
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    Amministratore
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    United KingdomBritish58720360003
    ALLY, Bibi Rahima
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    Segretario
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    British38963210007
    HARRIS, Philip Bernard
    85 Western Road
    Ealing
    W5 5DT London
    Segretario
    85 Western Road
    Ealing
    W5 5DT London
    British54037970002
    LEWIS, Paul Raymond Thomas
    11 Wellfield Gardens
    SM5 4EA Carshalton Beeches
    Surrey
    Segretario
    11 Wellfield Gardens
    SM5 4EA Carshalton Beeches
    Surrey
    British147923250001
    MARSHALL, Brent Austin
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    Segretario
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    167691820001
    WINGFIELD, Richard Alan
    Town Farm Close
    OX9 2DA Thame
    1
    Oxfordshire
    Segretario
    Town Farm Close
    OX9 2DA Thame
    1
    Oxfordshire
    149795610001
    BANNER & ASSOCIATES LTD
    29 Byron Road
    HA1 1JR Harrow
    Middlesex
    Segretario nominato
    29 Byron Road
    HA1 1JR Harrow
    Middlesex
    900011090001
    BEYNSBERGER, David
    6 Coombe Hill Court
    SL4 4UL Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    6 Coombe Hill Court
    SL4 4UL Windsor
    Berkshire
    British52160540001
    CLARK, Robert Ian
    25 Carpenders Close
    AL5 3HN Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    25 Carpenders Close
    AL5 3HN Harpenden
    Hertfordshire
    British78415290002
    FAUX, Sarah
    3 Glenmore House
    Richmond Hill
    TW10 6BQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    3 Glenmore House
    Richmond Hill
    TW10 6BQ Richmond
    Surrey
    British84672680001
    HARRIS, Philip Bernard
    85 Western Road
    Ealing
    W5 5DT London
    Amministratore
    85 Western Road
    Ealing
    W5 5DT London
    United KingdomBritish54037970002
    KENT, James
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    Amministratore
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    United KingdomBritish148367460001
    LANGMORE, Michael
    28 Russell Road
    HA6 2LR Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    28 Russell Road
    HA6 2LR Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish11172280001
    LEWIS, Paul Raymond Thomas
    11 Wellfield Gardens
    SM5 4EA Carshalton Beeches
    Surrey
    Amministratore
    11 Wellfield Gardens
    SM5 4EA Carshalton Beeches
    Surrey
    United KingdomBritish147923250001
    MARSHALL, Brent Austin
    Southdowns
    The Avenue Clifton
    BS8 3GE Bristol
    Flat 7
    United Kingdom
    Amministratore
    Southdowns
    The Avenue Clifton
    BS8 3GE Bristol
    Flat 7
    United Kingdom
    EnglandBritish167689850001
    OLISA, Kenneth Aphunezi, Sir
    18 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    18 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HP Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish31705700001
    PARKER, Nicholas
    Crome Hill
    Ashridge Park
    HP4 1NP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Crome Hill
    Ashridge Park
    HP4 1NP Berkhamsted
    Hertfordshire
    British70897450001
    PORTLOCK, Michael Kenneth
    Skimbleshanks
    Hook Heath Road
    GU22 0LE Woking
    Surrey
    Amministratore
    Skimbleshanks
    Hook Heath Road
    GU22 0LE Woking
    Surrey
    British63903230001
    RANSOM, Graham Richard
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    UkBritish34690210001
    ROGERS, Derek
    42 Belvedere Road
    SE19 2HW London
    Amministratore
    42 Belvedere Road
    SE19 2HW London
    EnglandBritish73548000001
    TAILOR, Pravin
    Chess Way
    Chorley Wood
    WD3 5TA Rickmansworth
    Fairwinds
    Hertfordshire
    Amministratore
    Chess Way
    Chorley Wood
    WD3 5TA Rickmansworth
    Fairwinds
    Hertfordshire
    United KingdomBritish23960250003
    VITHALDAS, Vim
    6 The Chase
    Great Amwell
    SG12 9TN Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 The Chase
    Great Amwell
    SG12 9TN Ware
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59433340003
    WINGFIELD, Richard Alan
    Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    1
    Oxon
    Amministratore
    Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    1
    Oxon
    EnglandBritish76932830002
    BANNER NOMINEES LTD
    29 Byron Road
    HA1 1JR Harrow
    Middlesex
    Amministratore delegato nominato
    29 Byron Road
    HA1 1JR Harrow
    Middlesex
    900011080001

    CALLCENTRIC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission
    Creato il 09 mar 2007
    Consegnato il 19 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The credit balance being any sum standing to the credit of an account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Omnibus guarantee & set off agreement
    Creato il 02 mar 2007
    Consegnato il 12 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company charges under the agreement its credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 mar 2007
    Consegnato il 12 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 08 mar 2004
    Consegnato il 15 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more companies including any accounts in the banks name with any designation which includes the names of the companies or any one or more of the companies. (The accounts). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 17 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any one or more of the companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more companies including any accounts in the bank name with any designation which includes the name of the companies or any one or more of the companies.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 set 2002
    Consegnato il 25 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any principal debtor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Point-on Holdings Limited
    Transazioni
    • 25 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 nov 1998
    Consegnato il 01 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 lug 1997
    Consegnato il 23 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0