ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03370146
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    33 Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRANSWORLD HEALTHCARE (UK) LIMITED27 mag 199727 mag 1997
    PURELUCKY LIMITED14 mag 199714 mag 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Carl Michael Brown come amministratore in data 29 nov 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Collison come segretario in data 29 nov 2018

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Cavendish House Lakhpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX England a 33 Glasshouse Street London W1B 5DG in data 02 dic 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Joanne Machin come amministratore in data 01 nov 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Luca Warnke come amministratore in data 01 nov 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    17 pagineAA

    Nomina di Dr Caspaar Friedrich Trautwein come amministratore in data 03 ago 2018

    2 pagineAP01

    Stato del capitale al 06 lug 2018

    • Capitale: GBP 100
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 25/06/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Miss Joanne Machin come amministratore in data 01 ago 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Henry Whitehead come amministratore in data 12 giu 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Carl Michael Brown come amministratore in data 12 giu 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di David Collison come amministratore in data 31 gen 2017

    1 pagineTM01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TRAUTWEIN, Caspaar Friedrich, Dr
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    Amministratore
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    GermanyGerman249111890001
    COLLISON, David
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    Segretario
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    204256890001
    DAVIES, John
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    166608020001
    HAYNES, Victoria
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British182412280001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    PALLADINO, Wayne A
    25 Mereland Road
    NEW YORK New Rochelle
    10804
    Segretario
    25 Mereland Road
    NEW YORK New Rochelle
    10804
    Usa64401390001
    PALLADINO, Wayne A
    25 Mereland Road
    NEW YORK New Rochelle
    10804
    Segretario
    25 Mereland Road
    NEW YORK New Rochelle
    10804
    Usa64401390001
    STRINGER, Andrew Paul
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    171546320001
    WADDELL, Ian Francis
    Muirside Glebe Lane
    Hartley Wintney
    RG27 8EA Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    Muirside Glebe Lane
    Hartley Wintney
    RG27 8EA Basingstoke
    Hampshire
    British28497990001
    WESTWOOD, Philip John
    Allied Healthcare Group Limited
    Stone Business Park Brooms Road
    ST15 0TL Stone
    Staffordshire
    Segretario
    Allied Healthcare Group Limited
    Stone Business Park Brooms Road
    ST15 0TL Stone
    Staffordshire
    British71727490001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AITKEN, Timothy Maxwell
    870 Fifth Avenue Apt 14e
    NY 10021 New York
    Usa
    Amministratore
    870 Fifth Avenue Apt 14e
    NY 10021 New York
    Usa
    British65840370004
    BATEMAN, Stephen John
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish133761180001
    BROWN, Carl Michael
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    Amministratore
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    EnglandBritish232841280001
    COLLISON, David
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Amministratore
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    United KingdomBritish34835160001
    EAMES, Sarah Ladd
    Flat F 34 Cadogan Square
    SW1X 0JL London
    Amministratore
    Flat F 34 Cadogan Square
    SW1X 0JL London
    American75443640001
    EAMES, Sarah L
    5 Westwoodcourt
    NEW YORK Harrison
    10528
    Usa
    Amministratore
    5 Westwoodcourt
    NEW YORK Harrison
    10528
    Usa
    Usa64401310001
    ELLIS, Martyn Anthony
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish95749550002
    FINE, Robert
    111 Ashley Avenue
    Brielle
    New Jersey
    08730
    Usa
    Amministratore
    111 Ashley Avenue
    Brielle
    New Jersey
    08730
    Usa
    American54235090001
    FISHER, Amanda Lucia
    The Rowans
    Merretts Orchard
    GL2 7DS Sumbridge
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Rowans
    Merretts Orchard
    GL2 7DS Sumbridge
    Gloucestershire
    EnglandBritish174485990001
    GIBSON, Darryn Stanley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomNew Zealander177930490001
    GREEN, George Richard
    Selhurst Park House,
    Selhurst Park, Halnaker
    PO18 0LZ Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Selhurst Park House,
    Selhurst Park, Halnaker
    PO18 0LZ Chichester
    West Sussex
    EnglandBritish4795650003
    GREEN, George Richard
    Selhurst Park House,
    Selhurst Park, Halnaker
    PO18 0LZ Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Selhurst Park House,
    Selhurst Park, Halnaker
    PO18 0LZ Chichester
    West Sussex
    EnglandBritish4795650003
    HOWARD, Stuart Michael
    c/o Saga Healthcare
    Enbrook Park
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    England
    Amministratore
    c/o Saga Healthcare
    Enbrook Park
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    England
    United KingdomBritish160271430001
    IVERS, John Joseph
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish77692980002
    JOHNSON, David Ian
    6 Mill Farm Court
    Chebsey
    ST21 6HZ Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    6 Mill Farm Court
    Chebsey
    ST21 6HZ Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish46008570001
    KERNAHAN, Charles Lloyd
    The Old Barn Main Street
    Sutton On Trent
    NG23 6PF Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Old Barn Main Street
    Sutton On Trent
    NG23 6PF Newark
    Nottinghamshire
    British50116330001
    LAVERY, Daniel Mark
    23 Cornwall House
    Portland Crescent
    HG1 2TR Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    23 Cornwall House
    Portland Crescent
    HG1 2TR Harrogate
    North Yorkshire
    British111619010001
    MACHIN, Joanne
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Amministratore
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    EnglandBritish236304960001
    MASON, Catherine Lois
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Amministratore
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    EnglandBritish224233880001
    MOFFATT, David Stewart
    2 Lawrence Gardens
    Mill Hill
    NW7 4JT London
    Amministratore
    2 Lawrence Gardens
    Mill Hill
    NW7 4JT London
    EnglandBritish88747420001
    MOSELEY, Frederick
    173 Larch Row
    Wenham
    Massachussetts Ma 01984
    Usa
    Amministratore
    173 Larch Row
    Wenham
    Massachussetts Ma 01984
    Usa
    American67910480001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Allied Healthcare Group Holdings Limited
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    06 apr 2016
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England And Wales
    Numero di registrazione3890177
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating security document
    Creato il 19 lug 2004
    Consegnato il 28 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 28 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash collateral account
    Creato il 22 gen 2003
    Consegnato il 06 feb 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the cash collateral account and the charged balance where the account is the interest bearing sterling deposit account opened maintained and held by the chargee with account number 50451347 sort code 20-77-67 and designated barclays bank re staffing enterprise loan note account which includes any sub-account re-designation or substitution of said account. The charged balance means all monies standing to the credit of the cash collateral account with all interest accruing therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over collateral account
    Creato il 15 ott 2002
    Consegnato il 28 ott 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in the cash collateral account being the interest bearing sterling deposit account opened maintained and held by the chargee with account number 80358355 sort code 20-77-67 and designated barclays bank re j s bal loan note account and includes any sub-account any redesignation of that account and any account substituted as the cash collateral account by written agreement between the parties, and the charged balance being all monies from time to time standing to the credit of the cash collateral account together with the interest accruing thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over cash collateral account
    Creato il 30 lug 2002
    Consegnato il 09 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The cash collateral account and the charged balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A charge over earn out account and acquisition expenditure account made by the company in favour of barclays bank PLC as security agent for and on behalf of the beneficiaries set out in the intercreditor deed (the "security agent")
    Creato il 27 set 2001
    Consegnato il 05 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations owing to the beneficiaries or to the security agent (whether for its own account or on behalf of the beneficiaries) by the obligors under or pursuant to the finance documents (including the debenture) whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or surety or in some other capacity)
    Brevi particolari
    Each credit balance from time to time on the earn out account number 20421677 sort code 20-77-67 and on the acquisition expenditure account number 30776576.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A charge over cash collateral account
    Creato il 27 set 2001
    Consegnato il 05 ott 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan note guarantee facility
    Brevi particolari
    All monies from time to time standing to the credit of the sterling deposit account number 20478776 sort code 20-77-67 with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over cash collateral account
    Creato il 02 ago 2001
    Consegnato il 09 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the loan note guarantee facility of even date
    Brevi particolari
    All its right title and interest in the cash collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash collateral account
    Creato il 15 giu 2001
    Consegnato il 27 giu 2001
    In corso
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee (the guarantee bank) under the loan note guarantee facility (as defined)
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all its right title and interest in all monies from time to time standing to the credit of the cash collateral account - account no.90076120. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 17 dic 1999
    Consegnato il 23 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations of transworld healthcare (UK) limited (the obligor) to the chargee as agent and security agent for and on behalf of the beneficiaries on the terms and conditions set out in the intercreditor deed under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 dic 1999
    Consegnato il 23 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations of transworld healthcare (UK) limited (the obligor) to the chargee as agent and security agent for and on behalf of the beneficiaries on the terms and conditions set out in the intercreditor deed under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0