MORRISON MERLIN LIMITED

MORRISON MERLIN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMORRISON MERLIN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03371720
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MORRISON MERLIN LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova MORRISON MERLIN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    31 Bruton Place
    W1J 6NN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MORRISON MERLIN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MORRISON MERLIN LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MORRISON MERLIN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 lug 2015

    Stato del capitale al 17 lug 2015

    • Capitale: GBP 9,369,065
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 giu 2014

    Stato del capitale al 19 giu 2014

    • Capitale: GBP 9,369,065
    SH01

    Bilancio redatto al 31 ott 2013

    15 pagineAA

    Nomina di Mrs Valérie Jeanine Ingelbrecht come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Severine Desnos come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Xavier Pullen come amministratore

    2 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2013 al 31 ott 2013

    3 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 52 Grosvenor Gardens London SW1W 0AU* in data 12 nov 2013

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Stuart Wetherly come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Kenneth Ford come amministratore

    2 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 033717200019

    43 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 09 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di MORRISON MERLIN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INGELBRECHT, Valérie Jeanine
    Bruton Place
    W1J 6NN London
    31
    Segretario
    Bruton Place
    W1J 6NN London
    31
    184383560001
    DESNOS, Severine Geraldine Marie
    Bruton Place
    W1J 6NN London
    31
    Amministratore
    Bruton Place
    W1J 6NN London
    31
    FranceFrench182808250001
    DESAI, Falguni Rameshchandra
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    Segretario
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    British77755390004
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Segretario
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    British1500260013
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    WETHERLY, Stuart Andrew
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    Segretario
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    177523200001
    FETTER SECRETARIES LIMITED
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    Segretario
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    71203580001
    DESAI, Falguni Rameshchandra
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    Amministratore
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    EnglandBritish77755390004
    DICK, Robert John Westwater
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    Amministratore
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    British246770002
    DONNELLY, Anthony
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    Amministratore
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    United KingdomBritish109258700001
    FORD, Kenneth Charles
    Hans Place
    SW1X 0JZ London
    43
    Amministratore
    Hans Place
    SW1X 0JZ London
    43
    EnglandBritish52710005
    FRITH, Roger Mark
    4 Avenue South
    KT5 8PJ Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    4 Avenue South
    KT5 8PJ Surbiton
    Surrey
    British79071980001
    JEFFERSON, Andrew Gordon
    17 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    17 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Midlothian
    British63406350001
    JEVANS, Peter Theodore
    White Cottage
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    White Cottage
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritish35560390001
    JURY, Graham Richard
    6 Strachan Place
    SW19 4RH London
    Amministratore
    6 Strachan Place
    SW19 4RH London
    British5973370001
    LAWSON, Andrew Gordon
    One The Paddock Seton Mains
    EH32 0PG Longniddry
    East Lothian
    Amministratore
    One The Paddock Seton Mains
    EH32 0PG Longniddry
    East Lothian
    British45002240001
    MACCONNELL, Alasdair Murray
    3 Kettil'stoun Court
    EH49 6PS Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    3 Kettil'stoun Court
    EH49 6PS Linlithgow
    West Lothian
    ScotlandBritish54405740002
    MONK, Allan
    Lyncroft 2 Ryburn Avenue
    Beardwood
    BB2 7AU Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    Lyncroft 2 Ryburn Avenue
    Beardwood
    BB2 7AU Blackburn
    Lancashire
    British57852540001
    PULLEN, Xavier
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    Amministratore
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    EnglandBritish78912170008
    RUSSELL, Peter
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    Amministratore
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    EnglandBritish10920180001
    SUNNUCKS, William D'Urban
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    Amministratore
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    EnglandBritish32866350001
    WALLACE, Lesley Ann
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    British64383520003
    WINWARD, Martin Johnson
    Entwhistle House
    Entwhistle
    BL7 0LR Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Entwhistle House
    Entwhistle
    BL7 0LR Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish17166820001
    FETTER INCORPORATIONS LIMITED
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    Amministratore
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    71203570001

    MORRISON MERLIN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 ott 2013
    Consegnato il 08 nov 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H land k/a great northern centre watson street manchester t/no.GM829282. L/h k/a civic square peter street manchester t/no.GM796494. F/h land k/a land forming part of great bridgewater street manchester t/no.GM794105. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transazioni
    • 08 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of comfirmation
    Creato il 04 ott 2005
    Consegnato il 11 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 17 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east side of deansgate manchester t/n GM829282, l/h civic square peter street manchester t/n GM796494, f/h great bridgewater street manchester t/n GM794105 the proceeds of sale and benefit of covenants.
    Persone aventi diritto
    • Capital & Regional PLC
    Transazioni
    • 17 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 17 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Capital & Regional PLC
    Transazioni
    • 17 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 06 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 06 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Its right title and interest in and the benefit of the agreements for lease, the developments documents, all amounts due under anu development documents and the benefit of any guarantee or security. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security over a deposit in a bank or building society
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 06 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the secured accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 06 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the property k/a land and buildings on the east isde of deansgate manchester t/n GM829282 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 05 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Awg Group Limited
    Transazioni
    • 05 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 05 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Awg Developments Limited
    Transazioni
    • 05 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 05 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Morrison Merlin Great Northern Limited
    Transazioni
    • 05 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 05 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Firstly all that f/h property known as land and buildings on the east side of deansgate, manchester t/n GM829282. Secondly all that l/h property known as the civic square, peter street, manchester t/n GM796494. Thirdly all that f/h property forming part of great bridgewater street, manchester t/n GM794105. Together with all buildings, fixtures and other structures. By way of fixed equitable charge, any beneficial interest the company may have in the property, in any compensation or insurance money and in any proceeds of sale, the benefit of the personal covenants.
    Persone aventi diritto
    • Awg Group Limited
    Transazioni
    • 05 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 05 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Firstly all that f/h property known as land and buildings on the east side of deansgate, manchester t/n GM829282. Secondly all that l/h property known as the civic square, peter street, manchester t/n GM796494. Thirdly all that f/h property forming part of great bridgewater street, manchester t/n GM794105. Together with all buildings, fixtures and other structures. By way of fixed equitable charge, any beneficial interest the company may have in the property, in any compensation or insurance money and in any proceeds of sale, the benefit of the personal covenants.
    Persone aventi diritto
    • Awg Developments Limited
    Transazioni
    • 05 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 05 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Firstly all that f/h property known as land and buildings on the east side of deansgate, manchester t/n GM829282. Secondly all that l/h property known as the civic square, peter street, manchester t/n GM796494. Thirdly all that f/h property forming part of great bridgewater street, manchester t/n GM794105. Together with all buildings, fixtures and other structures. By way of fixed equitable charge, any beneficial interest the company may have in the property, in any compensation or insurance money and in any proceeds of sale, the benefit of the personal covenants.
    Persone aventi diritto
    • Morrison Merlin Great Northern Limited
    Transazioni
    • 05 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 nov 1999
    Consegnato il 26 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the financing documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Immobilienbank as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of benefits and certain contracts and rights
    Creato il 19 nov 1999
    Consegnato il 26 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the credit agreement and the hedging contract and any of the security documents as defined therein
    Brevi particolari
    All right title and interest in each of the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Immobilienbank as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 lug 1998
    Consegnato il 31 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land shown edged in red on the plan attached to the debenture being part of the land under t/nos. GM711671 and GM713228 and fronting deansgate manchester city centre. L/h land shown edged green on the plan being land fronting peter street and watson street manchester city centre and l/h land shown edged purple on the plan being land situated between windmill street and watson street manchester city centre. Floating charge over all undertaking other property assets and rights including stock in trade and book debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Urban Regeneration Agency (Known as English Partnerships)
    Transazioni
    • 31 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 lug 1998
    Consegnato il 24 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (including without limitation, all monies, obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the bank under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or the principal deed) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a great northern warehouse manchester t/no: GM711671 and l/h land situated at watson street manchester t/no: GM342200 (part) all buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures) and fixed plant and machinery thereon floating charge over all its undertaking assets and rights .. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 24 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 lug 1997
    Consegnato il 09 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (including without limitation all monies, obligations and liabilities hereafter due or owing or incurred to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined)) and/or this deed and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 09 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0