SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED

SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03372510
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?

    • (8531) /

    Dove si trova SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bridge House, Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Tetley Beazley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Philip Reiter il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mahboob Ali Merchant il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Fraser David Gregory il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Ellerby il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    legacy

    5 pagine363a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 07/01/2009
    RES13

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    11 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Segretario
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Amministratore
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270001
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Amministratore
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    REITER, Simon Philip
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    Amministratore
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    United KingdomBritish135845570001
    BHAYANI, Hitesh Prahbudas
    24 Mountington Park Close
    HA3 0NW Harrow
    Middlesex
    Segretario
    24 Mountington Park Close
    HA3 0NW Harrow
    Middlesex
    British69162500001
    DALY, Geoffrey William Stuart
    97 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LX London
    Segretario
    97 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LX London
    British19464860001
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Segretario
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Segretario
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001
    BHAYANI, Hitesh Prahbudas
    24 Mountington Park Close
    HA3 0NW Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    24 Mountington Park Close
    HA3 0NW Harrow
    Middlesex
    British69162500001
    BHAYANI, Sudhen Prabhudas
    80 Barn Hill
    HA9 9LQ Wembley
    Middlesex
    Amministratore
    80 Barn Hill
    HA9 9LQ Wembley
    Middlesex
    EnglandBritish43452460001
    DALY, Geoffrey William Stuart
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    Amministratore
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    United KingdomBritish19464860003
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DHANDSA, Narinder, Dr
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    Amministratore
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    EnglandBritish115844000001
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    RAINER, Christopher Nihal
    20 West Hill
    Sanderstead
    CR2 0SA South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    20 West Hill
    Sanderstead
    CR2 0SA South Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish55660630001
    SINCLAIR BROWN, Frederick John
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish8070730003
    SINCLAIR BROWN, Frederick John
    13 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    Amministratore
    13 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    British8070730001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Amministratore
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003
    WACKETT, Leonard Walter
    46 Bramber Way
    RH15 8JX Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    46 Bramber Way
    RH15 8JX Burgess Hill
    West Sussex
    British48549700001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001
    WICKER, Frederick Alan
    39 Lloyd Road
    KT4 8SA Worcester Park
    Surrey
    Amministratore
    39 Lloyd Road
    KT4 8SA Worcester Park
    Surrey
    United KingdomEnglish1969460001
    ANS NOMINEES LIMITED
    1 Battersea Square
    SW11 3PZ London
    Amministratore
    1 Battersea Square
    SW11 3PZ London
    68699250001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 gen 2004
    Consegnato il 14 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 giu 2003
    Consegnato il 08 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fieldway nursing home, mitcham, surrey t/n TGL103067 and any buildings fixtures fittings fixed plant or machinery and all related rights. All the company's right title and interest to in and under all proceeds of any insurance policy and all related rights and all agreements contracts deeds licences undertakings guarantees covenants warranties representations and other documents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 08 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 giu 2003
    Consegnato il 17 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest from time to time in and to each of the following assets the real property, the tangible moveable property, the account, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares all monetary claims. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 17 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 lug 2002
    Consegnato il 05 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 lug 2002
    Consegnato il 05 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a filedway nursery and residential care home south of tramway park mitcham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 lug 1999
    Consegnato il 16 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a the fieldway nursing centre mitcham l/b of merton greater london t/no: TGL103067. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 lug 1999
    Consegnato il 16 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 ago 1997
    Consegnato il 19 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 due from the company to the chargee in accordance with the provisions of clause 6.8 of a deed dated 19TH june 1997
    Brevi particolari
    Land and buildings at tramway path mitcham t/n-TGL103067.
    Persone aventi diritto
    • Ans Staff Services (Sutton Court) Limited
    Transazioni
    • 19 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of a building contract relating to a development of a freehold nursing home at tramway path,mitcham,title no.tgl 103067
    Creato il 19 giu 1997
    Consegnato il 09 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    All rights under the building contract. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 giu 1997
    Consegnato il 09 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over bank accounts
    Creato il 19 giu 1997
    Consegnato il 09 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in the account monies on acct/no 60518077. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 giu 1997
    Consegnato il 09 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property - tramway path,mitcham; t/no tgl 103067 with the goodwill of business and all licences,guarantees and covenants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0