GARETH JAMES PHARMACY LIMITED

GARETH JAMES PHARMACY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGARETH JAMES PHARMACY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03375701
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GARETH JAMES PHARMACY LIMITED?

    • (5231) /

    Dove si trova GARETH JAMES PHARMACY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sandbrook Park, Sandbrook Way
    Rochdale
    OL11 1RY Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GARETH JAMES PHARMACY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al10 gen 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per GARETH JAMES PHARMACY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Smith il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Branson Nuttall il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mag 2010

    Stato del capitale al 20 mag 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Peter Batty come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Caroline Jane Sellers come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Katherine Eldridge come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 10 gen 2009

    20 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 12 gen 2008

    20 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 lug 2007

    23 pagineAA

    legacy

    6 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine225

    Chi sono gli amministratori di GARETH JAMES PHARMACY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SELLERS, Caroline Jane
    Sandbrook Park, Sandbrook Way
    Rochdale
    OL11 1RY Lancashire
    Segretario
    Sandbrook Park, Sandbrook Way
    Rochdale
    OL11 1RY Lancashire
    150066860001
    NUTTALL, John Branson
    13 Green Villa Park
    SK9 6EJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    13 Green Villa Park
    SK9 6EJ Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritish44967060002
    SMITH, Anthony John
    Three Mile Lane
    ST5 5HW Whitmore
    Hillside Lodge
    Staffordshire
    Amministratore
    Three Mile Lane
    ST5 5HW Whitmore
    Hillside Lodge
    Staffordshire
    EnglandBritish137558680001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Segretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    JAMES, Susan Laura
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    Segretario
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    British53038800002
    MATHIAS, Clive Stanley
    1 The Mews
    St Nicholas Road
    CF62 6QX Barry
    Vale Of Glamorgan
    Segretario
    1 The Mews
    St Nicholas Road
    CF62 6QX Barry
    Vale Of Glamorgan
    British90539780002
    SELLERS, Caroline Jane
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    Segretario
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    British45801060004
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Amministratore
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    DUGGAN, Rachel
    18 Mentone Road
    Heaton Moor
    SK4 4HF Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    18 Mentone Road
    Heaton Moor
    SK4 4HF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish122443900001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Amministratore
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    JAMES, Gareth Lloyd
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    Amministratore
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    WalesBritish58499330001
    JAMES, Susan Laura
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    Amministratore
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    WalesBritish53038800002
    JONES, Ailsa Michelle
    16 Northways
    CF36 5LB Porthcawl
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    16 Northways
    CF36 5LB Porthcawl
    Mid Glamorgan
    British116649550001
    WANLISS, Mike
    2 Ridgeview
    Off Scott Close
    LE16 7GJ Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    2 Ridgeview
    Off Scott Close
    LE16 7GJ Market Harborough
    Leicestershire
    British120288660001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001
    FARMERS FABRICATIONS LIMITED
    Eos House
    Weston Square
    CF63 2YF Barry
    South Glamorgan
    Amministratore
    Eos House
    Weston Square
    CF63 2YF Barry
    South Glamorgan
    44551190001

    GARETH JAMES PHARMACY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 giu 2006
    Consegnato il 01 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ago 2005
    Consegnato il 30 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a the pharmacy llanybydder dyfed. Fixed and floating charge over undertaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 30 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy intination dated 17/03/04 and
    Creato il 11 mar 2004
    Consegnato il 18 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Company: scottish provident, policy number: 12184958, date: 16/04/2003, sum: £1,300,000, life assured: gareth lloyd james/susan laura james together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy intimation dated 17/03/04 and
    Creato il 11 mar 2004
    Consegnato il 18 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Company: scottish provident, policy number: 12182633, sum: £2800000, life assured: gareth lloyd james/susan laura james together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 giu 2003
    Consegnato il 13 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2003
    Consegnato il 13 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Peglers building, 1-5 pontardulais road, gorseinon, swansea t/n CYM39275. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2003
    Consegnato il 13 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 alexandra road, gorseinon t/n WA930290. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2003
    Consegnato il 13 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    47/49 charles street, milford haven t/n CYM15196. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mag 2002
    Consegnato il 11 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H property the new pharmacy gowerton surgery mill street gowerton swansea.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transazioni
    • 11 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 giu 2001
    Consegnato il 09 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H peglers building 1-5 pontardulais road gorseinon swansea and all rights attached or appurtenant to it and all buildings fixtures fititngs plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transazioni
    • 09 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 nov 2000
    Consegnato il 25 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property 2 alexandra road gorseinon swansea 150-152 station road llanelli 33 terrace road aberystwyth fixed and floating charges over the undertaking and all property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transazioni
    • 25 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 2000
    Consegnato il 14 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property k/a 47/49 charles street milford haven pembrokshire fixed charge all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transazioni
    • 14 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 nov 1999
    Consegnato il 18 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 33 terrace road aberystwyth any goodwill of any business. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transazioni
    • 18 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 nov 1999
    Consegnato il 18 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 2 alexandra road gorseinon swansea any goodwill of any business. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transazioni
    • 18 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 nov 1999
    Consegnato il 18 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 150/152 station road llanelli any goodwill of any business. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transazioni
    • 18 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 ott 1999
    Consegnato il 26 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transazioni
    • 26 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 nov 1998
    Consegnato il 04 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transazioni
    • 04 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 01 giu 1998
    Consegnato il 04 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property being 33 terrace rd,aberystwyth. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mar 1998
    Consegnato il 18 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 giu 1997
    Consegnato il 18 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first floating charge all its undertaking and property both present and future including its uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0