BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED

BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBORDER RADIO HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03376590
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Keenan il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Deidre Ann Ford il 30 set 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Jane Vickery il 30 set 2016

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2016 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Nomina di Bauer Group Secretariat Limited come segretario in data 05 mag 2016

    2 pagineAP04

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 lug 2016

    Stato del capitale al 28 lug 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Jane Vickery il 14 lug 2016

    3 pagineCH01

    Nomina di Mrs Sarah Jane Vickery come amministratore in data 05 mag 2016

    3 pagineAP01

    Nomina di Deidre Ann Ford come amministratore in data 05 mag 2016

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Anthony Keenan come amministratore in data 05 mag 2016

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philip Stephen Riley come amministratore in data 05 mag 2016

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Roy Evans come segretario in data 05 mag 2016

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Mark Roy Evans come amministratore in data 05 mag 2016

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 172 10/06/2016
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Segretario
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish119137220004
    CUSICK, Nicholas Jonathan Paul
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    Segretario
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    British50942120001
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    British54693600002
    FITZJOHN, Julie
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    Segretario
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    British92875290001
    FLUET, Cliff
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    Segretario
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    British97684290001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Segretario
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Irish116537370001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    SCHWARZ, Nathalie Esther
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    Segretario
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    British59245010001
    BROWNLOW, Peter
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    Amministratore
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    British4459070001
    BURGESS, Robert Lawie Frederick
    Hall Flatt
    Scaleby
    CA6 4LE Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Hall Flatt
    Scaleby
    CA6 4LE Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish61711750001
    CORLEY, Paul
    3 Willoughby Street
    WC1A 1JD London
    Amministratore
    3 Willoughby Street
    WC1A 1JD London
    British60591660003
    EVANS, Mark Roy
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish54693600002
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish54693600002
    FAIRBURN, Paul Martin
    9 Tansley Gardens
    Dorridge
    B93 8UB Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    9 Tansley Gardens
    Dorridge
    B93 8UB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish43039880003
    FITZJOHN, Julie
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    Amministratore
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    United KingdomBritish92875290001
    GRAHAM, James Lowery
    Oak House
    Great Corby
    CA4 8NE Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Oak House
    Great Corby
    CA4 8NE Carlisle
    Cumbria
    British2014530001
    HARRIS, Peter Jonathan
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    Amministratore
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    EnglandBritish40917640001
    MANSFIELD, David James
    16 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    Amministratore
    16 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    United KingdomBritish32585450001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Irish116537370001
    MYERS, John Frederick
    21 Middle Drive
    Darras Hal
    NE20 9DH Ponteland
    Northumberland
    Amministratore
    21 Middle Drive
    Darras Hal
    NE20 9DH Ponteland
    Northumberland
    British70386430001
    PARK, Richard Francis Jackson
    55 Gloucester Crescent
    NW1 7EG London
    Amministratore
    55 Gloucester Crescent
    NW1 7EG London
    EnglandBritish75081070002
    QUINN, Andrew
    Kilnholme
    Penton
    CA6 5QZ Carlisle
    Amministratore
    Kilnholme
    Penton
    CA6 5QZ Carlisle
    British42394270002
    RILEY, Philip Stephen
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish140085310001
    TABOR, Ashley Daniel
    Apartment 11-02
    The Knightsbridge Apartments, 199 Knightsbridge
    SW17 1RH London
    Amministratore
    Apartment 11-02
    The Knightsbridge Apartments, 199 Knightsbridge
    SW17 1RH London
    United KingdomBritish56313240002
    THOMSON, Donald Alexander
    Shelley Lodge
    104 West Street
    SL7 2BP Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Shelley Lodge
    104 West Street
    SL7 2BP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish37668550003
    TRIMBLE, David William
    Deepdale
    Dalston
    CA5 7BH Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Deepdale
    Dalston
    CA5 7BH Carlisle
    Cumbria
    British11476910001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06 apr 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3050677
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the note issuer and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Price
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 20 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Matthew Paul Ramsbottom
    Transazioni
    • 20 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 20 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert John Norman
    Transazioni
    • 20 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 18 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Geoffrey Percy
    Transazioni
    • 18 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 13 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from orion media holdings limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Global Radio Group Limited
    Transazioni
    • 13 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Philip Riley
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery a specific equitable charge over all freehold & leasehold properties &/or the proceeds of sale thereof, fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present & future including goodwill, book debts & the benefit of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Antony Thomas Lloyd
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 05 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All land vested in or charged to the chargor, all fixtures and fittings attached to the land and all rents, all plant & machinery, contacts goodwill uncalled capital stocks shares patents copyrights and all other intellectual property rights. A floating charge over all the other property assets and rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 09 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0