SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03379663
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Altre attività di pubblicazione di software (58290) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DEMOABLE LIMITED02 giu 199702 giu 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 mag 2016

    28 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 mag 2015

    LRESSP

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 7

    5 pagineMR05

    Bilancio redatto al 31 mag 2014

    15 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Paul Woodward come amministratore in data 05 set 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sanjay Patel come amministratore in data 28 ago 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Van Harken come amministratore in data 31 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Mary Collins come amministratore in data 31 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 giu 2014

    Stato del capitale al 04 giu 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2013

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Misys Corporate Director Limited come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joanna Hawkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Misys Corporate Secretary Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Sanjay Patel come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Elizabeth Mary Collins come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bijal Patel come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Joanna Marageret Hawkes come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Bijal Mahendra Patel il 20 mag 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2012

    15 pagineAA

    Nomina di Mr Bijal Mahendra Patel come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    Amministratore
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid, Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    Segretario
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid, Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    British147213550001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Segretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Segretario
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Segretario
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione07036299
    170449400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAULME, Herve
    23 Avenue De L'Obersavtoire
    75006 Paris
    France
    Amministratore
    23 Avenue De L'Obersavtoire
    75006 Paris
    France
    French98573020001
    BELLOUARD, Xavier Henry Marie
    14 Abinger Road
    W4 1EL London
    Amministratore
    14 Abinger Road
    W4 1EL London
    LondonFrench53755850003
    BRIODY, Dermot
    Palm Drive
    The Redhill Peninsula
    Tai Tam
    House 34
    Hong Kong
    Hong Kong
    Amministratore
    Palm Drive
    The Redhill Peninsula
    Tai Tam
    House 34
    Hong Kong
    Hong Kong
    Irish128090250001
    CAPPELL, Mark Stanley
    Woodruff
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Woodruff
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    United KingdomAmerican103054980001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    DE FONTENAY, Jean
    440 East 62nd Street
    NY 10021 New York
    Usa
    Amministratore
    440 East 62nd Street
    NY 10021 New York
    Usa
    French53755800002
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish75357260001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HELSBY, Frank Peter
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish34237710003
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    Amministratore
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    HUGHES, Kevin Gerard
    12 Linkdale
    CM12 9QW Billericay
    Essex
    Amministratore
    12 Linkdale
    CM12 9QW Billericay
    Essex
    British2659400001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Amministratore
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    MOLONEY, Barry William
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish48187880001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    SARGANT, Murray
    10d, Block D, Grenville House
    No1 Magazine Gap Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    Amministratore
    10d, Block D, Grenville House
    No1 Magazine Gap Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    Australian113006830001
    SOAMES, Rupert Christopher
    Ridge Barn Farm House
    Ridgebarn Lane, Cuddington
    HP18 0AE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ridge Barn Farm House
    Ridgebarn Lane, Cuddington
    HP18 0AE Aylesbury
    Buckinghamshire
    ScotlandBritish86671010001
    STONELL, Keith Robert
    Tars Platt
    Cookham Dean Common
    SL6 9PY Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Tars Platt
    Cookham Dean Common
    SL6 9PY Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish151579610001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 lug 2012
    Consegnato il 06 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All property,all the shares and investments and all corresponding related rights first fixed charge all other interests in any property and the benefit of all other agreements relating to land,all of its right title and interest in the charged intellectual property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse Ag,Cayman Islands Branch
    Transazioni
    • 06 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 mag 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 12 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Creato il 23 ott 2002
    Consegnato il 13 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Creato il 09 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 ott 2017Data di scioglimento
    27 mag 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Praticante
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0