HALLMARK INDUSTRIES LIMITED

HALLMARK INDUSTRIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHALLMARK INDUSTRIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03385127
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (1300) LIMITED11 giu 199711 giu 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    20 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2021

    20 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2020

    19 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2019

    15 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Orion House 5 Upper St. Martin's Lane London WC2H 9EA England a Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road Whitefield M45 7TA in data 06 dic 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 nov 2018

    LRESSP

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    17 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Parag Himatlal Gandesha come amministratore in data 06 apr 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 giu 2016

    Stato del capitale al 02 giu 2016

    • Capitale: GBP 26,819,730.66
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Mml Capital Partners Llp Grand Buildings 1-3 Strand London WC2N 5HR a Orion House 5 Upper St. Martin's Lane London WC2H 9EA in data 12 gen 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2015

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 giu 2015

    Stato del capitale al 19 giu 2015

    • Capitale: GBP 26,819,730.66
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2014

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mag 2014

    Stato del capitale al 27 mag 2014

    • Capitale: GBP 26,819,730.66
    SH01

    Nomina di Mr Parag Himatlal Gandesha come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Highland House 165 the Broadway Wimbledon London SW19 1NE England* in data 04 feb 2014

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROOKS, Roderick Hilary
    c/o Mml Capital Partners Llp
    1-3 Strand
    WC2N 5HR London
    Grand Buildings
    England
    Amministratore
    c/o Mml Capital Partners Llp
    1-3 Strand
    WC2N 5HR London
    Grand Buildings
    England
    United KingdomBritish64784320003
    JOHAL, Balbinder Singh
    c/o Mml Capital Partners Llp
    1-3 Strand
    WC2N 5HR London
    Grand Buildings
    England
    Amministratore
    c/o Mml Capital Partners Llp
    1-3 Strand
    WC2N 5HR London
    Grand Buildings
    England
    United KingdomBritish124684440001
    WALLIS, Ian Scott
    Grand Buildings
    Strand
    WC2N 5HR London
    1-3
    United Kingdom
    Amministratore
    Grand Buildings
    Strand
    WC2N 5HR London
    1-3
    United Kingdom
    EnglandBritish129726790001
    FOX, Andrew Joseph
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    Segretario
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    British73079390002
    GIBSON, John
    Shaws Farm
    NE48 2JU Bellingham
    Northumberland
    Segretario
    Shaws Farm
    NE48 2JU Bellingham
    Northumberland
    British19815410001
    PENMAN, Angus Warwick
    7 Red Anchor Close
    Old Church Street Chelsea
    SW3 5DW London
    Segretario
    7 Red Anchor Close
    Old Church Street Chelsea
    SW3 5DW London
    British44192700001
    SCOTT, Christopher George
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    Segretario
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    British94183390001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    BOLAND, Robert Jerome
    15 Manchester Road
    SK10 2EH Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    15 Manchester Road
    SK10 2EH Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish70534810001
    DAVIDSON, George Alexander
    The Waterfront
    300 Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Waterfront
    300 Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish60518410002
    DAVIES, Colin Ernest
    The Granary
    Escrick Road
    YO19 6BQ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Granary
    Escrick Road
    YO19 6BQ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78759470002
    FOX, Andrew Joseph
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    Amministratore
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    EnglandBritish73079390002
    GANDESHA, Parag Himatlal
    5 Upper St. Martin's Lane
    WC2H 9EA London
    Orion House
    England
    Amministratore
    5 Upper St. Martin's Lane
    WC2H 9EA London
    Orion House
    England
    United KingdomBritish142573260001
    GIBSON, John
    Shaws Farm
    NE48 2JU Bellingham
    Northumberland
    Amministratore
    Shaws Farm
    NE48 2JU Bellingham
    Northumberland
    British19815410001
    GORDON CLARK, Matthew John
    104 Cloudesley Road
    N1 0EB London
    Amministratore
    104 Cloudesley Road
    N1 0EB London
    United KingdomBritish101313810001
    KENT, Brian Hamilton
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    Amministratore
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    United KingdomBritish15133080001
    PENMAN, Angus Warwick
    7 Red Anchor Close
    Old Church Street Chelsea
    SW3 5DW London
    Amministratore
    7 Red Anchor Close
    Old Church Street Chelsea
    SW3 5DW London
    EnglandBritish44192700001
    RASORES, Manny
    3 Villiers Grove
    SM2 7NN Cheam
    Surrey
    Amministratore
    3 Villiers Grove
    SM2 7NN Cheam
    Surrey
    Spanish106219810001
    RICHARDSON, Stewart Thomas
    Granary House Long Lane
    LU5 6HG Toddington
    Bedfordshire
    Amministratore
    Granary House Long Lane
    LU5 6HG Toddington
    Bedfordshire
    British56686210003
    SCHMID, Christian
    Untere Haldenstrasse 31
    Wohlen
    FOREIGN 5610
    Switzerland
    Amministratore
    Untere Haldenstrasse 31
    Wohlen
    FOREIGN 5610
    Switzerland
    Swiss102634990001
    SCOTT, Christopher George
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish94183390001
    SMALL, Brian William
    Saturday House
    Church Lane
    NN13 5QT Helmdon
    Northampshire
    Amministratore
    Saturday House
    Church Lane
    NN13 5QT Helmdon
    Northampshire
    British24329080002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    27 mag 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    HALLMARK INDUSTRIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 ott 2007
    Consegnato il 26 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • International Mezzanine Investment N.V
    Transazioni
    • 26 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Creato il 12 ott 2007
    Consegnato il 19 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policy being p/no LO191250952 life assured christopher scott insurer scottish equitable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Key-man policies assignment
    Creato il 25 ago 1999
    Consegnato il 31 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the policies numbered L01948767801 L0199367801 L0192667801 and all monies including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Key-man policies assignment
    Creato il 21 dic 1998
    Consegnato il 22 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the policies numbered L0194867801, L0194867801, L0194867801 and all moneys including bonuses accued. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transazioni
    • 22 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 23 set 1998
    Consegnato il 07 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the senior finance documents or the mezzanine finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee for the Beneficiaries(As Defined)
    Transazioni
    • 07 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 mar 1998
    Consegnato il 30 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities on the debenture date or in the future due,owing or incurred from the company and all or any of the other companies named therein to the governor and company of the bank of scotland as security trustee for the beneficiaries (as defined) and to each of the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share pledge agreement which was executed outside the united kingdom comprising property situated outside the united kingdom
    Creato il 11 mar 1998
    Consegnato il 30 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the governor and company of the bank of scotland (the security trustee) out of or in connection with the facilities agreement dated 12TH march 1998 and to international mezzanine capital B.V. (imc) out of or in connection with the mezzanine loan agreement dated 12TH march 1998
    Brevi particolari
    All shares in graystone gmbh (the company) and all shares the pledgor will acquire in the company from time to time and all purchase or subscription rights relating to the shares pledged in the agreement and resulting from an increase of share capital and all present and future claims for profit distribution. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandand International Mezzanine Capital Bv
    Transazioni
    • 30 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    • 10 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter of charge
    Creato il 10 nov 1997
    Consegnato il 27 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from airmatic engineering (UK) limited, cableform limited, campden instruments limited, flowcool systems limited, greenspear products limited, h a birch & company limited, inter cable systems limited, parking & equipment services limited, portobello fabrications limited and thomas eaves limited to the governor and company of the bank of scotland
    Brevi particolari
    All monies now or at any time standing to the credit of any account or accounts of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of shares
    Creato il 10 nov 1997
    Consegnato il 26 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement (as defined) and the mortgage deed
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the shares and all rights moneys benefits and other property deriving or accruing therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • International Mezzanine Capital Bv
    Transazioni
    • 26 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HALLMARK INDUSTRIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 nov 2018Inizio della liquidazione
    29 set 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Conrad Alan Beighton
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Praticante
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Steve Markey
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester
    Praticante
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0