HALLMARK INDUSTRIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HALLMARK INDUSTRIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03385127 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road M45 7TA Whitefield |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BROOMCO (1300) LIMITED | 11 giu 1997 | 11 giu 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 20 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2021 | 20 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2020 | 19 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2019 | 15 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Orion House 5 Upper St. Martin's Lane London WC2H 9EA England a Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road Whitefield M45 7TA in data 06 dic 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Parag Himatlal Gandesha come amministratore in data 06 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Mml Capital Partners Llp Grand Buildings 1-3 Strand London WC2N 5HR a Orion House 5 Upper St. Martin's Lane London WC2H 9EA in data 12 gen 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2015 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Parag Himatlal Gandesha come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Highland House 165 the Broadway Wimbledon London SW19 1NE England* in data 04 feb 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKS, Roderick Hilary | Amministratore | c/o Mml Capital Partners Llp 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings England | United Kingdom | British | 64784320003 | |||||
| JOHAL, Balbinder Singh | Amministratore | c/o Mml Capital Partners Llp 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings England | United Kingdom | British | 124684440001 | |||||
| WALLIS, Ian Scott | Amministratore | Grand Buildings Strand WC2N 5HR London 1-3 United Kingdom | England | British | 129726790001 | |||||
| FOX, Andrew Joseph | Segretario | 165 The Broadway Wimbledon SW19 1NE London Highland House England | British | 73079390002 | ||||||
| GIBSON, John | Segretario | Shaws Farm NE48 2JU Bellingham Northumberland | British | 19815410001 | ||||||
| PENMAN, Angus Warwick | Segretario | 7 Red Anchor Close Old Church Street Chelsea SW3 5DW London | British | 44192700001 | ||||||
| SCOTT, Christopher George | Segretario | 120 Lady Byron Lane Knowle B93 9BA Solihull West Midlands | British | 94183390001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||
| BOLAND, Robert Jerome | Amministratore | 15 Manchester Road SK10 2EH Macclesfield Cheshire | England | British | 70534810001 | |||||
| DAVIDSON, George Alexander | Amministratore | The Waterfront 300 Thames Valley Park Drive RG6 1PT Reading Berkshire | United Kingdom | British | 60518410002 | |||||
| DAVIES, Colin Ernest | Amministratore | The Granary Escrick Road YO19 6BQ York North Yorkshire | United Kingdom | British | 78759470002 | |||||
| FOX, Andrew Joseph | Amministratore | 165 The Broadway Wimbledon SW19 1NE London Highland House England | England | British | 73079390002 | |||||
| GANDESHA, Parag Himatlal | Amministratore | 5 Upper St. Martin's Lane WC2H 9EA London Orion House England | United Kingdom | British | 142573260001 | |||||
| GIBSON, John | Amministratore | Shaws Farm NE48 2JU Bellingham Northumberland | British | 19815410001 | ||||||
| GORDON CLARK, Matthew John | Amministratore | 104 Cloudesley Road N1 0EB London | United Kingdom | British | 101313810001 | |||||
| KENT, Brian Hamilton | Amministratore | 165 The Broadway Wimbledon SW19 1NE London Highland House England | United Kingdom | British | 15133080001 | |||||
| PENMAN, Angus Warwick | Amministratore | 7 Red Anchor Close Old Church Street Chelsea SW3 5DW London | England | British | 44192700001 | |||||
| RASORES, Manny | Amministratore | 3 Villiers Grove SM2 7NN Cheam Surrey | Spanish | 106219810001 | ||||||
| RICHARDSON, Stewart Thomas | Amministratore | Granary House Long Lane LU5 6HG Toddington Bedfordshire | British | 56686210003 | ||||||
| SCHMID, Christian | Amministratore | Untere Haldenstrasse 31 Wohlen FOREIGN 5610 Switzerland | Swiss | 102634990001 | ||||||
| SCOTT, Christopher George | Amministratore | 120 Lady Byron Lane Knowle B93 9BA Solihull West Midlands | England | British | 94183390001 | |||||
| SMALL, Brian William | Amministratore | Saturday House Church Lane NN13 5QT Helmdon Northampshire | British | 24329080002 | ||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 27 mag 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
HALLMARK INDUSTRIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 12 ott 2007 Consegnato il 26 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment of keyman life policy | Creato il 12 ott 2007 Consegnato il 19 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The policy being p/no LO191250952 life assured christopher scott insurer scottish equitable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Key-man policies assignment | Creato il 25 ago 1999 Consegnato il 31 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari All right title and interest in and to the policies numbered L01948767801 L0199367801 L0192667801 and all monies including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Key-man policies assignment | Creato il 21 dic 1998 Consegnato il 22 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari All its right title and interest in and to the policies numbered L0194867801, L0194867801, L0194867801 and all moneys including bonuses accued. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental charge | Creato il 23 set 1998 Consegnato il 07 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the senior finance documents or the mezzanine finance documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 mar 1998 Consegnato il 30 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities on the debenture date or in the future due,owing or incurred from the company and all or any of the other companies named therein to the governor and company of the bank of scotland as security trustee for the beneficiaries (as defined) and to each of the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share pledge agreement which was executed outside the united kingdom comprising property situated outside the united kingdom | Creato il 11 mar 1998 Consegnato il 30 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the governor and company of the bank of scotland (the security trustee) out of or in connection with the facilities agreement dated 12TH march 1998 and to international mezzanine capital B.V. (imc) out of or in connection with the mezzanine loan agreement dated 12TH march 1998 | |
Brevi particolari All shares in graystone gmbh (the company) and all shares the pledgor will acquire in the company from time to time and all purchase or subscription rights relating to the shares pledged in the agreement and resulting from an increase of share capital and all present and future claims for profit distribution. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge | Creato il 10 nov 1997 Consegnato il 27 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from airmatic engineering (UK) limited, cableform limited, campden instruments limited, flowcool systems limited, greenspear products limited, h a birch & company limited, inter cable systems limited, parking & equipment services limited, portobello fabrications limited and thomas eaves limited to the governor and company of the bank of scotland | |
Brevi particolari All monies now or at any time standing to the credit of any account or accounts of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage of shares | Creato il 10 nov 1997 Consegnato il 26 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement (as defined) and the mortgage deed | |
Brevi particolari All the company's right title and interest in and to the shares and all rights moneys benefits and other property deriving or accruing therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
HALLMARK INDUSTRIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0