A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED

A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàA.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03385342
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o WELL
    Merchants Warehouse
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (1295) LIMITED11 giu 199711 giu 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al11 gen 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Angel Square Manchester M60 0AG a C/O Well Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ in data 14 set 2015

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 ago 2015

    Stato del capitale al 04 ago 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 pagineAD02

    Nomina di Miss Caroline Hilton come segretario in data 11 dic 2014

    2 pagineAP03

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 11 gen 2015 al 30 giu 2015

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Caroline Jane Sellers come segretario in data 30 set 2014

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 11/08/2014
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 ago 2014

    Stato del capitale al 04 ago 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 ago 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 15 ago 2013

    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2013

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* in data 03 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Smith il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Branson Nuttall il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2010

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HILTON, Caroline
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Segretario
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    193402920001
    NUTTALL, John Branson
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Amministratore
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    United KingdomBritish44967060002
    SMITH, Anthony John
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Amministratore
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    EnglandBritish137558680001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Segretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Segretario
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    MARKS, Philip Louis Howard
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    British55339760001
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150261920001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Segretario
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375350001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    DAVIS, Estelle Denise
    41 The Mount
    LS17 7RH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    41 The Mount
    LS17 7RH Leeds
    West Yorkshire
    British55339780001
    EVANS, Nia Haf
    6 Thorneyholme Drive
    WA16 8BT Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    6 Thorneyholme Drive
    WA16 8BT Knutsford
    Cheshire
    British85570730001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Amministratore
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    MARKS, Peter Vincent
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish87486470001
    MARKS, Philip Louis Howard
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    British55339760001
    MURRAY, James William Masterson
    30 Riversdale
    Woolston
    WA1 4PZ Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    30 Riversdale
    Woolston
    WA1 4PZ Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish106429280001
    NUTTALL, John Branson
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    British44967060001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375270001

    A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 05 nov 1997
    Consegnato il 12 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the f/h and l/h property of the company,including the property k/a 203 kirkstall lane,leeds and the proceeds of sale thereof together with all buildings,structures and fixtures from time to time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0