CHARCOL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHARCOL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03397767
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHARCOL LIMITED?

    • (6512) /

    Dove si trova CHARCOL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHARCOL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JOHN CHARCOL (BIRMINGHAM) LIMITED03 lug 199703 lug 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHARCOL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per CHARCOL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    9 pagine4.72

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine2.34B

    Cessazione della carica di Imogen Coggan come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Imogen Coggan come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jane Mcmahon come amministratore

    2 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 ago 2010

    6 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    8 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    24 pagine2.17B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    24 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Chancery House 53- 64 Chancery Lane London WC2A 1QU United Kingdom in data 13 apr 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    8 pagineMG01

    legacy

    8 pagineMG01

    Dettagli del direttore cambiati per Jane Elizabeth Mc Mahon il 01 gen 2009

    1 pagineCH01

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    21 pagineAA

    legacy

    9 pagine395

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di CHARCOL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AVRILI, Walter Anthony
    Carrick House
    Carrick Lane
    GU46 6XN Yateley
    Hampshire
    Amministratore
    Carrick House
    Carrick Lane
    GU46 6XN Yateley
    Hampshire
    United KingdomBritish102119310001
    GARFIELD, John Stuart Godwin
    2 Farmer Street
    Nottinghill Gate
    W8 7SN London
    Amministratore
    2 Farmer Street
    Nottinghill Gate
    W8 7SN London
    UkBritish22311780012
    LAWTON, Michael John
    Albany Road
    GU51 3LY Fleet
    14
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Albany Road
    GU51 3LY Fleet
    14
    Hampshire
    United Kingdom
    British134156000001
    COGGAN, Imogen Frances Lytton
    Griffiths Road
    SW19 1ST London
    72
    United Kingdom
    Segretario
    Griffiths Road
    SW19 1ST London
    72
    United Kingdom
    British134061130001
    FRENKEL, John Richard
    28 Kingsley Way
    N2 0EW London
    Segretario
    28 Kingsley Way
    N2 0EW London
    British127384780001
    JORDAN, Paul Gary
    Lindale 9 Back O' The Beck
    BD23 1PH Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    Lindale 9 Back O' The Beck
    BD23 1PH Skipton
    North Yorkshire
    British100972090001
    MURISON, Robert William
    59 Lordington
    PO18 9DX Chichester
    West Sussex
    Segretario
    59 Lordington
    PO18 9DX Chichester
    West Sussex
    British97871790001
    RAWLINSON, Paul Victor
    15 Torwood House
    Torwood Lane
    CR3 0HD Whyteleafe
    Surrey
    Segretario
    15 Torwood House
    Torwood Lane
    CR3 0HD Whyteleafe
    Surrey
    British12127500003
    SHANKLEY, Alan Forbes
    34 Queens Road
    LS29 9QJ Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    34 Queens Road
    LS29 9QJ Ilkley
    West Yorkshire
    British7591870001
    WISHART, Charles George Mackenzie
    3 Lyall Mews
    SW1X 8DJ London
    Segretario
    3 Lyall Mews
    SW1X 8DJ London
    British60654460001
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    BANKS, Duncan Stuart
    Prospect Road
    AL1 2AT St. Albans
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Prospect Road
    AL1 2AT St. Albans
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135148110001
    BARRETT, Peter Charles
    Meadowside
    Piltdown
    TN22 3XD Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Meadowside
    Piltdown
    TN22 3XD Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritish94805030001
    BOLTON, Richard Peter
    37 Claremount Gardens
    KT18 5XF Epsom
    Surrey
    Amministratore
    37 Claremount Gardens
    KT18 5XF Epsom
    Surrey
    British63844170002
    COGGAN, Imogen Frances Lytton
    Griffiths Road
    SW19 1ST London
    72
    United Kingdom
    Amministratore
    Griffiths Road
    SW19 1ST London
    72
    United Kingdom
    United KingdomBritish134061130001
    DARBY, Ian Stuart
    Swanthorpe Barn
    Crondall
    GU10 5PY Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Swanthorpe Barn
    Crondall
    GU10 5PY Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish77702700004
    DARBY, Ian Stuart
    Swanthorpe Barn
    Crondall
    GU10 5PY Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Swanthorpe Barn
    Crondall
    GU10 5PY Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish77702700004
    EATWELL, Emma
    37 Woodcote House
    Updown Hill
    RH16 4GQ Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    37 Woodcote House
    Updown Hill
    RH16 4GQ Haywards Heath
    West Sussex
    British126637850001
    FRASER, Richard Cullen
    8 The Park
    Grasscroft
    OL4 4ES Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    8 The Park
    Grasscroft
    OL4 4ES Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritish49677170001
    FRENKEL, John Richard
    28 Kingsley Way
    N2 0EW London
    Amministratore
    28 Kingsley Way
    N2 0EW London
    British127384780001
    HODGSON, Candice Juliet
    Flat 7
    8 Nevern Square
    SW5 9NW London
    Amministratore
    Flat 7
    8 Nevern Square
    SW5 9NW London
    South African102118810001
    JONES, Trevor
    37 Harley Street
    W1G 8QG London
    Amministratore
    37 Harley Street
    W1G 8QG London
    British102230160001
    KENNEDY, Ian David
    Abacus
    Lansdown Road
    BA1 5TD Bath
    Amministratore
    Abacus
    Lansdown Road
    BA1 5TD Bath
    United KingdomBritish93804080003
    KORNITZER, Clive David
    4 Parham Way
    Muswell Hill
    N10 2AT London
    Amministratore
    4 Parham Way
    Muswell Hill
    N10 2AT London
    United KingdomBritish78559240001
    MATTHEWS, Colin
    10 St Davids Drive
    Englefield Green
    TW20 0BA Egham
    Surrey
    Amministratore
    10 St Davids Drive
    Englefield Green
    TW20 0BA Egham
    Surrey
    EnglandBritish65470880001
    MCINERNEY, Jeremy James
    18 Crossgate Mews
    Harrow Molsey
    SK4 3AP Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    18 Crossgate Mews
    Harrow Molsey
    SK4 3AP Stockport
    Cheshire
    British56718130001
    MCMAHON, Jane Elizabeth
    Sailmakers Court
    William Morris Court
    SW6 2UX London
    19
    United Kingdom
    Amministratore
    Sailmakers Court
    William Morris Court
    SW6 2UX London
    19
    United Kingdom
    EnglandBritish56812870005
    MURISON, Robert William
    59 Lordington
    PO18 9DX Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    59 Lordington
    PO18 9DX Chichester
    West Sussex
    EnglandBritish97871790001
    OKEY, Ricky John
    72 Wattleton Road
    HP9 1RY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    72 Wattleton Road
    HP9 1RY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British94706140001
    PALMER, Martin John
    15 Beaconsfield Road
    BS8 2TS Bristol
    Amministratore
    15 Beaconsfield Road
    BS8 2TS Bristol
    EnglandBritish105086120001
    PARKER, Paul
    9 Chestnut Walk
    Groby
    LE6 0EU Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    9 Chestnut Walk
    Groby
    LE6 0EU Leicester
    Leicestershire
    British65440140001
    RAWLINSON, Paul Victor
    15 Torwood House
    Torwood Lane
    CR3 0HD Whyteleafe
    Surrey
    Amministratore
    15 Torwood House
    Torwood Lane
    CR3 0HD Whyteleafe
    Surrey
    British12127500003
    SCOTT, Keith Royston
    Goffs Farm London Road
    Northchapel
    GU28 9EQ Petworth
    West Sussex
    Amministratore
    Goffs Farm London Road
    Northchapel
    GU28 9EQ Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritish62864200003
    SHARPE, Robert
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British79424780004
    SHUTTLEWORTH, Barbara Mary
    30 Sandringham Road
    Boothstown Worsley
    M28 1LX Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    30 Sandringham Road
    Boothstown Worsley
    M28 1LX Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish49147640001

    CHARCOL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 feb 2010
    Consegnato il 18 feb 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Jon Moulton Charles Wishart and John Garfield
    Transazioni
    • 18 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 19 gen 2010
    Consegnato il 26 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Insurance policies, investments and receivables see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jon Moulton, Charles Wishart and John Garfield
    Transazioni
    • 26 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Omnibus guarantee & set off agreement
    Creato il 10 nov 2008
    Consegnato il 21 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 10 nov 2008
    Consegnato il 21 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 16 giu 2005
    Consegnato il 29 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    £24,494 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The rent deposit and the amount standing from time to time to the credit of a designated deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Universal Pension Trustees Limited
    Transazioni
    • 29 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 18 feb 1998
    Consegnato il 25 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CHARCOL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 feb 2010Inizio dell'amministrazione
    23 feb 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Praticante
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    2
    DataTipo
    23 feb 2011Inizio della liquidazione
    03 gen 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Praticante
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0