BMP ASSOCIATES LIMITED

BMP ASSOCIATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBMP ASSOCIATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03399962
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BMP ASSOCIATES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BMP ASSOCIATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Fore Royal
    Gorley Road
    BH24 3LD Ringwood
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BMP ASSOCIATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per BMP ASSOCIATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 30 nov 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 lug 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 08 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 lug 2016

    Stato del capitale al 06 lug 2016

    • Capitale: GBP 1,750,000
    SH01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 25 gen 2016

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 12 ago 2015

    2 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    5 pagineRM02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di David James Bull come amministratore in data 06 nov 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    17 pagineAA

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Bilancio annuale redatto al 08 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 lug 2014

    Stato del capitale al 28 lug 2014

    • Capitale: GBP 1,750,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ago 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 06 ago 2013

    SH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di BMP ASSOCIATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    IRESON, Christie Joelle
    Fore Royal Gorley Road
    Linbrook
    BH24 3LD Ringwood
    Hampshire
    Segretario
    Fore Royal Gorley Road
    Linbrook
    BH24 3LD Ringwood
    Hampshire
    British105296040001
    FANELLI, Nicola
    Fore Royal
    Gorley Road Rockford
    BH24 3LD Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Fore Royal
    Gorley Road Rockford
    BH24 3LD Ringwood
    Hampshire
    EnglandItalian63908350002
    ANDERSON, Colin
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    Dorset
    British80202100001
    BULL, David James
    40 Chilfrome Close
    BH17 9WE Poole
    Dorset
    Segretario
    40 Chilfrome Close
    BH17 9WE Poole
    Dorset
    British44811930002
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Segretario nominato
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004240001
    BULL, David James
    40 Chilfrome Close
    BH17 9WE Poole
    Dorset
    Amministratore
    40 Chilfrome Close
    BH17 9WE Poole
    Dorset
    EnglandBritish44811930002
    CORTI, Massimo
    Via R Simen 9
    6830 Chiasso
    FOREIGN Switzerland
    Amministratore
    Via R Simen 9
    6830 Chiasso
    FOREIGN Switzerland
    Swiss46512650001
    SIA, Francesca
    Flat 42 Forest House
    1 Russell Cotes Road
    BN1 3UB Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    Flat 42 Forest House
    1 Russell Cotes Road
    BN1 3UB Bournemouth
    Dorset
    Italian60976240001
    CONSULTANCY AND ADVISORY BUREAU LIMITED
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    Dorset
    64583810001
    HELITING COMPANY ADMINISTRATION LIMITED
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    Amministratore
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    66523600001
    KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004230001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BMP ASSOCIATES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Cesare Romiti
    Gorley Road
    BH24 3LD Ringwood
    Fore Royal
    Hampshire
    06 apr 2016
    Gorley Road
    BH24 3LD Ringwood
    Fore Royal
    Hampshire
    No
    Nazionalità: Italian
    Paese di residenza: Italy
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    BMP ASSOCIATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture deed
    Creato il 18 nov 2009
    Consegnato il 19 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage
    Creato il 13 mar 2008
    Consegnato il 15 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a miller house 43-51 lower stone street maidstone kent together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 120 ago 2014Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 105 feb 2016Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 105 feb 2016Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 1
    Legal charge
    Creato il 22 giu 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    F/H miller house 43/51 lower stone street maidstone kent.
    Persone aventi diritto
    • Dansk-Europaeisk Finansiering Aps
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 giu 2005
    Consegnato il 07 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    A maximum of £1,000,000 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    Property k/a miller house, 43/51 lower stone street, maidstone, kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Dansk-Europaeisk Finansiering Aps
    Transazioni
    • 07 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 set 1997
    Consegnato il 14 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement
    Brevi particolari
    F/H property k/a 64-94 (even) attleborough road nuneaton warwickshire t/no WK327343 by way of floating charge all chattels fittings and other property ands assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Finzak Bv
    Transazioni
    • 14 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 set 1997
    Consegnato il 11 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as unit 2 meadowcourt phase 2 meadowhall road sheffie ld t/n syk 338705. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 lug 1997
    Consegnato il 30 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 149/165 victoria road aldershot hampshire t/n hp 353912. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BMP ASSOCIATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Michael Skinner
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Ricevitore/gestore
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Chris Wakeman
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Ricevitore/gestore
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0