HOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED

HOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03402204
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di HOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova HOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Strawberry Lane
    One Strawberry Lane
    NE1 4BX Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LIVE SMART @ HOME LIMITED19 set 200619 set 2006
    PARAMOUNT HOMES LIMITED16 ott 199816 ott 1998
    HOME SERVICES & LETTINGS LIMITED15 ago 199715 ago 1997
    PRECIS (1534) LIMITED11 lug 199711 lug 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2026
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2025

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al11 gen 2027
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma25 gen 2027
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al11 gen 2026
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per HOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2026 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2025

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2024

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Charlotte Ann Burnham come segretario in data 31 lug 2024

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Austin Woods come segretario in data 31 lug 2024

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2023

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Gideon Henderson il 06 feb 2023

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Gosforth Park Way Gosforth Business Park Newcastle upon Tyne NE12 8ET a One Strawberry Lane One Strawberry Lane Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 4BX in data 06 feb 2023

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Paul Walker come amministratore in data 23 nov 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matt Forrest come amministratore in data 23 nov 2022

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2022

    16 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Helen Brindley il 22 set 2022

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Russell John Hall come segretario in data 31 ago 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Charlotte Ann Burnham come segretario in data 01 set 2022

    2 pagineAP03

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed live smart @ home LIMITED\certificate issued on 03/08/22
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name03 ago 2022

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 09 mar 2022

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Ms Helen Brindley come amministratore in data 07 giu 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Matt Forrest come amministratore in data 07 giu 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Matthew Hudson come amministratore in data 07 giu 2022

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2021

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WOODS, Austin
    One Strawberry Lane
    NE1 4BX Newcastle Upon Tyne
    One Strawberry Lane
    Tyne And Wear
    England
    Segretario
    One Strawberry Lane
    NE1 4BX Newcastle Upon Tyne
    One Strawberry Lane
    Tyne And Wear
    England
    325627230001
    HENDERSON, Mark Gideon
    One Strawberry Lane
    NE1 4BX Newcastle Upon Tyne
    One Strawberry Lane
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    One Strawberry Lane
    NE1 4BX Newcastle Upon Tyne
    One Strawberry Lane
    Tyne And Wear
    England
    United KingdomBritish81681820003
    MEEHAN, Helen
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish298045320002
    WALKER, Paul
    One Strawberry Lane
    NE1 4BX Newcastle Upon Tyne
    One Strawberry Lane
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    One Strawberry Lane
    NE1 4BX Newcastle Upon Tyne
    One Strawberry Lane
    Tyne And Wear
    England
    EnglandBritish302582350001
    BURNHAM, Charlotte Ann
    One Strawberry Lane
    NE1 4BX Newcastle Upon Tyne
    One Strawberry Lane
    Tyne And Wear
    England
    Segretario
    One Strawberry Lane
    NE1 4BX Newcastle Upon Tyne
    One Strawberry Lane
    Tyne And Wear
    England
    299635130001
    DENT, Laurence
    Spade Rake
    35 Meadowfield Road
    NE43 7PY Stocksfield
    Northumberland
    Segretario
    Spade Rake
    35 Meadowfield Road
    NE43 7PY Stocksfield
    Northumberland
    British85030200001
    HALL, Russell John
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    253357660001
    MOORHOUSE, Stephen
    9 Methven Way
    NE23 3XQ Cramlington
    Northumberland
    Segretario
    9 Methven Way
    NE23 3XQ Cramlington
    Northumberland
    British73851280001
    THOMPSON, Steven
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    British139548630001
    WOODS, Austin Jonathan
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    British96758810001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Segretario
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROWN, Christopher Kenrick
    Nook House Farm
    Nook Lane
    CW9 6LA Antrobus
    Cheshire
    Amministratore
    Nook House Farm
    Nook Lane
    CW9 6LA Antrobus
    Cheshire
    United KingdomBritish45154550001
    BURNETT, James Murray
    438 Lanark Road
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    438 Lanark Road
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    British19234460001
    COOKE, Fra
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish131132080001
    DENT, Laurence
    Spade Rake
    35 Meadowfield Road
    NE43 7PY Stocksfield
    Northumberland
    Amministratore
    Spade Rake
    35 Meadowfield Road
    NE43 7PY Stocksfield
    Northumberland
    British85030200001
    DILLON, John Edward Michael
    1 Belsize Mews
    Belsize Park
    NW3 5AT London
    Amministratore
    1 Belsize Mews
    Belsize Park
    NW3 5AT London
    British29438580001
    DU ROSE, Rosemary
    Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2
    England
    Amministratore
    Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2
    England
    EnglandBritish168183400001
    FEE, Nigel Terry
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish83070690001
    FORREST, Matt
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish298027980001
    HEPPELL, James Whaley
    30 Green Close
    NE61 6PE Stannington
    Northumberland
    Amministratore
    30 Green Close
    NE61 6PE Stannington
    Northumberland
    EnglandBritish7952560002
    HOLMES, John David
    Edenview
    Station Road Corbridge
    NE45 5AY Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Edenview
    Station Road Corbridge
    NE45 5AY Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish53362390002
    HUDSON, John Matthew
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish298502720001
    HUNTER, Alexander Freeland Cairns
    The Old Doctors House
    High Street, Rothbury
    NE65 7TE Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    The Old Doctors House
    High Street, Rothbury
    NE65 7TE Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish64600130002
    KILBURN, Alan Edward
    132 Edge Hill
    Darras Hall
    NE20 9JL Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    132 Edge Hill
    Darras Hall
    NE20 9JL Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish17115280001
    LEVI, Malcolm
    23 Martingales Close
    TW10 7JJ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    23 Martingales Close
    TW10 7JJ Richmond
    Surrey
    EnglandBritish106645540001
    MAKIN, Jenny Susan
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish179705330001
    MCKENDRICK, Peter
    Stanegarth
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Stanegarth
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    Northumberland
    British59703160001
    PEARSON, Stephen John
    High Ash Avenue
    LS17 6RX Leeds
    79
    West Yorkshire
    Amministratore
    High Ash Avenue
    LS17 6RX Leeds
    79
    West Yorkshire
    United KingdomBritish42818060002
    PROLE, Alan Henry
    3 Park Gate
    Strensall
    YO32 5YL York
    Amministratore
    3 Park Gate
    Strensall
    YO32 5YL York
    Irish91800320002
    SHIRLEY, Peter Michael
    Crackendell Cottage
    Waterend Lane
    AL6 9BB Ayot St Peter Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Crackendell Cottage
    Waterend Lane
    AL6 9BB Ayot St Peter Welwyn
    Hertfordshire
    British38196760001
    STOTT, Peter
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2 Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish78209370001
    TURNER, Christine Anne
    17 Claremont Road
    St Margarets
    TW1 2QX Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    17 Claremont Road
    St Margarets
    TW1 2QX Twickenham
    Middlesex
    British75200530001
    WATSON, Jon Stuart
    68 Hackwood Park
    NE46 1AZ Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    68 Hackwood Park
    NE46 1AZ Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish41405840001
    WELBORN, Peter John
    Bayston House
    Cross Oak Road
    HP4 3HZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Bayston House
    Cross Oak Road
    HP4 3HZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish64980130002

    Chi sono le persone con controllo significativo di HOME GROUP REPAIRS PARTNERSHIP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Home Group Limited
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2 Gosforth Park Way
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2 Gosforth Park Way
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaRegistered Society
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCo-Operative And Community Benefit Societies Act 2014
    Luogo di registrazioneFinancial Conduct Authority
    Numero di registrazione22981r
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0