INNOVATIVE COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED

INNOVATIVE COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINNOVATIVE COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03403159
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INNOVATIVE COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova INNOVATIVE COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Metalrax Group Plc, Ardath
    Road, Kings Norton
    B38 9PN Birmingham
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INNOVATIVE COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IVYMOUNT LIMITED14 lug 199714 lug 1997

    Quali sono gli ultimi bilanci di INNOVATIVE COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per INNOVATIVE COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 07 gen 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Elizabeth Middleton come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Nicholas Longley come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Stock come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Nicholas Longley come segretario

    1 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    18 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Senior facilty agreement and cross debenture
    RES13

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    legacy

    20 pagineMG01

    legacy

    21 pagineMG01

    Dettagli del direttore cambiati per Elizabeth Jane Middleton il 02 ott 2009

    3 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    17 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di INNOVATIVE COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LONGLEY, Nicholas
    Ardath Road
    Kings Norton
    B38 9PN Birmingham
    Ardath Road
    England
    Segretario
    Ardath Road
    Kings Norton
    B38 9PN Birmingham
    Ardath Road
    England
    147388950001
    LONGLEY, Nicholas
    Ardath Road
    Kings Norton
    B38 9PN Birmingham
    Ardath Road
    England
    Amministratore
    Ardath Road
    Kings Norton
    B38 9PN Birmingham
    Ardath Road
    England
    EnglandBritishGroup Financial Controller147396410001
    RICHARDSON, Andrew John
    Warwick Road
    Chadwick End
    B93 0BU Solihull
    The Mews House
    West Midlands
    Amministratore
    Warwick Road
    Chadwick End
    B93 0BU Solihull
    The Mews House
    West Midlands
    BritishDirector132142760001
    FARRIMOND, Darren James
    5 Marsh Way
    Catshill
    B61 0JD Bromsgrove
    Segretario
    5 Marsh Way
    Catshill
    B61 0JD Bromsgrove
    British96411190001
    MIDDLETON, Elizabeth Jane
    40 Stonegate
    Cowbit
    PE12 6AH Spalding
    Lincolnshire
    Segretario
    40 Stonegate
    Cowbit
    PE12 6AH Spalding
    Lincolnshire
    BritishOperations54575610002
    MIDDLETON, Elizabeth Jane
    22 Independence Drive
    Pinchbeck
    PE11 3TR Spalding
    Lincolnshire
    Segretario
    22 Independence Drive
    Pinchbeck
    PE11 3TR Spalding
    Lincolnshire
    BritishAdministration Manager54575610001
    MOORE, Mark Robin Westwood
    81 North Road
    PE10 9BT Bourne
    Lincolnshire
    Segretario
    81 North Road
    PE10 9BT Bourne
    Lincolnshire
    British59273480001
    STOCK, Michael John
    WR9 7NH Tibberton
    Foredraught House
    Worcs
    Segretario
    WR9 7NH Tibberton
    Foredraught House
    Worcs
    British129726080001
    WHITE, Rachael Louise
    20 Shelton Road
    PE2 8QL Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    20 Shelton Road
    PE2 8QL Peterborough
    Cambridgeshire
    British66930830002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    ARBUTHNOT, Richard
    101 Dorridge Road
    Dorridge
    B93 8BS Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    101 Dorridge Road
    Dorridge
    B93 8BS Solihull
    West Midlands
    BritishBusines Director67470540001
    BROOK CARTER, Ronald Hedley
    Long Acre
    Rowney Green Lane
    B48 7QF Alvechurch
    West Midlands
    Amministratore
    Long Acre
    Rowney Green Lane
    B48 7QF Alvechurch
    West Midlands
    BritishDirector105094100001
    HARDING, Anthony Douglas
    4 Church Lane
    St Martins
    PE9 2JU Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    4 Church Lane
    St Martins
    PE9 2JU Stamford
    Lincolnshire
    BritishDirector43464310002
    HARDING, Jennifer Ann
    55 High Street
    St Martin's
    PE9 2LA Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    55 High Street
    St Martin's
    PE9 2LA Stamford
    Lincolnshire
    BritishCompany Director55132540001
    KELLY, William David
    Brantwood Keepers Lane
    The Wergs
    WV6 8UA Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Brantwood Keepers Lane
    The Wergs
    WV6 8UA Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomUnited KingdomDirector60285770001
    MIDDLETON, Elizabeth Jane
    C/O Metalrax Group Plc, Ardath
    Road, Kings Norton
    B38 9PN Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    C/O Metalrax Group Plc, Ardath
    Road, Kings Norton
    B38 9PN Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector54575610002
    MOORE, Mark Robin Westwood
    81 North Road
    PE10 9BT Bourne
    Lincolnshire
    Amministratore
    81 North Road
    PE10 9BT Bourne
    Lincolnshire
    BritishFinance Director59273480001
    PREEN, Martin John
    Bourne Eau House
    20 South Street
    PE10 9LT Bourne
    Lincolnshire
    Amministratore
    Bourne Eau House
    20 South Street
    PE10 9LT Bourne
    Lincolnshire
    United KingdomBritishChartered Accountant66946750005
    SALISBURY, Philip
    Newport Cottage
    Main Street Ufford
    PE9 3BH Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    Newport Cottage
    Main Street Ufford
    PE9 3BH Stamford
    Lincolnshire
    BritishDirector22182730002
    SANDBACH, Richard Paul Stainton
    51 Cedar Road
    PE9 2JJ Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    51 Cedar Road
    PE9 2JJ Stamford
    Lincolnshire
    EnglandBritishChartered Accountant1523030003
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    INNOVATIVE COMMERCIAL EQUIPMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 12 ott 2009
    Consegnato il 21 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 12 ott 2009
    Consegnato il 19 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Metalrax Group Pension Trustees Limited as Trustees of the Metalrax Group PLC Pension and Life Assurance Plan
    Transazioni
    • 19 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 mar 1999
    Consegnato il 24 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan note instrument of even date constituting £600,000 of 13.3% secured loan stock 2007 created by pmml limited
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Anthony Douglas Harding
    Transazioni
    • 24 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 set 1997
    Consegnato il 17 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fittings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0