PHP (HOUNSLOW) LIMITED
Panoramica
Nome della società | PHP (HOUNSLOW) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03407137 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PHP (HOUNSLOW) LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova PHP (HOUNSLOW) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 5th Floor Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PHP (HOUNSLOW) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PRIMARY HEALTH CARE CENTRES (HOUNSLOW) LIMITED | 22 lug 1997 | 22 lug 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PHP (HOUNSLOW) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PHP (HOUNSLOW) LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per PHP (HOUNSLOW) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip John Holland il 30 apr 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Nexus Management Services Limited come segretario in data 30 apr 2014 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Margaret Helen Vaughan come amministratore in data 30 apr 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor Ryder Court 14 Ryder Street London SW1Y 6QB England in data 07 mag 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di J O Hambro Capital Management Limited come segretario in data 30 apr 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 27 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Primary Health Care Centres Limited come amministratore in data 01 lug 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Margaret Helen Vaughan come amministratore in data 04 lug 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy David Walker-Arnott come amministratore in data 04 lug 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Philip John Holland come amministratore in data 04 lug 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey Green come amministratore in data 04 lug 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Harry Abraham Hyman come amministratore in data 04 lug 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di J O Hambro Capital Management Limited come segretario in data 04 lug 2013 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Deborah Ann Chisholm come segretario in data 04 lug 2013 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 28 feb 2014 al 31 dic 2013 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1a Chestnut House Farm Close Shenley Hertfordshire WD7 9AD in data 17 lug 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PHP (HOUNSLOW) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Segretario | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England |
| 57253330002 | ||||||||||
HOLLAND, Philip John | Amministratore | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | England | British | Chartered Accountant | 163838050001 | ||||||||
HYMAN, Harry Abraham | Amministratore | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | England | British | Chartered Accountant | 35560380005 | ||||||||
WALKER-ARNOTT, Timothy David | Amministratore | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | England | British | Chartered Surveyor | 131266520002 | ||||||||
CHISHOLM, Deborah Ann | Segretario | 14 Ryder Street SW1Y 6QB London Ground Floor Ryder Court England | 148524580001 | |||||||||||
CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED | Segretario nominato | Temple House 20 Holywell Row EC2A 4JB London | 900000860001 | |||||||||||
ELSTREE GATE TRUSTEES LIMITED | Segretario | 1a Chestnut House Farm Close WD7 9AD Shenley Hertfordshire | 113694740001 | |||||||||||
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Segretario | 14 Ryder Street SW1Y 6QB London Ground Floor Ryder Court England |
| 179878930001 | ||||||||||
KAY TRUSTEES LIMITED | Segretario | 6 Elstree Gate Elstree Way WD6 1JD Borehamwood Hertfordshire | 35347880002 | |||||||||||
BASTIAN, Nicholas Paul | Amministratore | 1 Hill House Cottages Old Mill Lane Bray SL6 2BB Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | Solicitor | 60010000010 | ||||||||
GREEN, Jeffrey | Amministratore | Quickmoor Farm Quickmoor Lane Common Wood WD4 9AX Kings Langley Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 39176460002 | ||||||||
MORTON-FIRTH, Christopher | Amministratore | 5 Saint Davids Drive Englefield Green TW20 0BA Egham Surrey | British | Company Director | 63495330002 | |||||||||
VAUGHAN, Margaret Helen | Amministratore | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 123167120001 | ||||||||
PRIMARY HEALTH CARE CENTRES LIMITED | Amministratore | Chestnut House Farm Close WD7 9AD Shenley 1a Hertfordshire |
| 117596750001 |
PHP (HOUNSLOW) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of assignment | Creato il 11 dic 2003 Consegnato il 12 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from primary health care centres limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/S. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of legal charge | Creato il 21 dic 1999 Consegnato il 23 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from primary health care centres limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of primary health care centres limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union PLC any company which is or becomes a holding company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever | |
Brevi particolari 134 bath road hounslow middlesex together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 3 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of legal charge | Creato il 19 nov 1999 Consegnato il 03 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,260,000 due or to become due from primary health care centres (hounslow) limited to the chargee pursuant to the provisions of the legal charge including further advances and all monies obligations and liabilities due or to become due from the company and primary health care centres limited or any holding company or subsidiary company of primary health care centres (hounslow) limited and primary health care centres limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property situate at 134 bath road hounslow and all fixtures and trade fixtures fittings and equipment by way of floating charge the company's whatsoever and wheresoever. Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0