OLD COMPANY 2 LIMITED
Panoramica
Nome della società | OLD COMPANY 2 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03407299 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OLD COMPANY 2 LIMITED?
- Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova OLD COMPANY 2 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Hampden House Great Hampden HP16 9RD Great Missenden England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di OLD COMPANY 2 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LEAD YACHT UNDERWRITERS LIMITED | 23 lug 1997 | 23 lug 1997 |
Quali sono gli ultimi bilanci di OLD COMPANY 2 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per OLD COMPANY 2 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2017 | 12 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 64 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Francis William Johnston il 09 mar 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Francis William Johnston come amministratore in data 30 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street London EC3V 4AG United Kingdom a Hampden House Great Hampden Great Missenden HP16 9rd in data 21 nov 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Hampden Legal Plc come segretario in data 30 ott 2017 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Notifica di Hampden Group Management Limited come persona con controllo significativo il 30 ott 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Ms Amlin Corporate Services Limited come persona con controllo significativo il 30 ott 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Malcolm Foster come amministratore in data 30 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Travis Alfred Bowles come amministratore in data 30 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Frances Moule come segretario in data 30 ott 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 16 ott 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di OLD COMPANY 2 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMPDEN LEGAL PLC | Segretario | Great Hampden HP16 9RD Great Missenden Hampden House Bucks England |
| 56301100002 | ||||||||||
JOHNSTON, Francis William | Amministratore | Great Hampden HP16 9RD Great Missenden Hampden House Bucks England | England | British | Chartered Accountant | 10965250001 | ||||||||
COTTON, Iain Mark Andrew | Segretario | 25 Oakwood Avenue CR8 1AR Purley Surrey | British | Insurance Underwriter | 108733020001 | |||||||||
MANSELL, Jeanette Mary | Segretario | 122 Leadenhall Street EC3V 4AG London The Leadenhall Building United Kingdom | British | 158236760001 | ||||||||||
MIROSEVIC SORGO, Vladimir Francis John | Segretario | 25 Buxton Gardens W3 9LF London | British | 60838810002 | ||||||||||
MOULE, Frances | Segretario | 122 Leadenhall Street EC3V 4AG London The Leadenhall Building United Kingdom | 212416210001 | |||||||||||
PEARSON, Janet Brenda | Segretario | 30 Queen Anne Road E9 7AH London | British | 65614910001 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
BOWLES, Travis Alfred | Amministratore | 122 Leadenhall Street EC3V 4AG London The Leadenhall Building United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 172853400002 | ||||||||
COTTON, Iain Mark Andrew | Amministratore | St Helens 1 Undershaft EC3A 8ND London | United Kingdom | British | Insurance Underwriter | 108733020001 | ||||||||
DOYLE, Kevin John | Amministratore | 26 Hillfield Drive Heswall L61 5UH Wirral Merseyside | British | Insurance | 51220820001 | |||||||||
FOSTER, Anthony Malcolm | Amministratore | 122 Leadenhall Street EC3V 4AG London The Leadenhall Building United Kingdom | England | British | Chartered Tax Advisor | 173431180001 | ||||||||
GRAHAM, Elizabeth Caroll | Amministratore | St Helens 1 Undershaft EC3A 8ND London | United Kingdom | British | Head Of Operations | 166444390002 | ||||||||
HARRIS, David Jonathan | Amministratore | St Helens 1 Undershaft EC3A 8ND London | England | British | Company Director | 226164350001 | ||||||||
HENSTRIDGE, Iain James | Amministratore | St Helens 1 Undershaft EC3A 8ND London | United Kingdom | British | Underwriter | 221451650001 | ||||||||
KING, Richard Giles | Amministratore | 46 Quilter Street E2 7BT London | British | Reinsurance Consultant | 20285870001 | |||||||||
LAURITZEN, Gonda | Amministratore | Ackerweg 7 30657 Hannover German | German | Insurance Executive | 45798800001 | |||||||||
MIROSEVIC SORGO, Vladimir Francis John | Amministratore | St Helens 1 Undershaft EC3A 8ND London | United Kingdom | British | Underwriter | 60838810003 | ||||||||
NORTON, Allan Robert | Amministratore | St Helens 1 Undershaft EC3A 8ND London | United Kingdom | British | Underwriter | 54764630002 | ||||||||
OVERALL, David Frederick | Amministratore | 1 Undershaft EC3A 8ND London St Helen's United Kingdom | England | British | Director | 146243750001 | ||||||||
POPE, Michael John | Amministratore | 25 Carrs Crescent West Formby L37 2EX Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | Underwriter | 51220670001 | ||||||||
POPE, Michael John | Amministratore | 25 Carrs Crescent West Formby L37 2EX Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | Insurance Underwriter | 51220670001 | ||||||||
RIPLEY, Andrew George | Amministratore | Morven House Dormansland RH7 6NZ Lingfield Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 9049710001 | ||||||||
SANGSTER, Peter Brian | Amministratore | 13 South Cliff Avenue TN39 3EB Bexhill On Sea East Sussex | United Kingdom | British | Consultant | 106074140001 | ||||||||
TURNER, David Glenn | Amministratore | 1 Undershaft EC3A 8ND London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 179240530001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di OLD COMPANY 2 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hampden Group Management Limited | 30 ott 2017 | Great Hampden HP16 9RD Great Missenden Hampden House Bucks England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Ms Amlin Corporate Services Limited | 06 apr 2016 | 122 Leadenhall Street EC3V 4AG London The Leadenhall Building United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
OLD COMPANY 2 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creato il 02 giu 1999 Consegnato il 18 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and richards and pearson to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined therein between the company and richards and person limited (as tenant) and the chargee (as landlord) relating to property being offices on part third floor forum house 15-18 lime street london EC3 | |
Brevi particolari All the company's right title benefit and interest in and to the deposit account opened in the name of the landlord in which the initial deposit sum of £6,800 is lodged and all related rights thereto and thereof under the terms of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 02 giu 1999 Consegnato il 04 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and richards and pearson limited to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Brevi particolari £6,800. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0